-
-
LISTERS CENTRAL LIMITED - Unit 2, Govan Road, Fenton Industrial Estate, Stoke-On-Trent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10948186
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 2
- Govan Road
- Fenton Industrial Estate
- Stoke-On-Trent
- ST4 2RS
- England Unit 2, Govan Road, Fenton Industrial Estate, Stoke-On-Trent, ST4 2RS, England UK
Management
- Geschäftsführung
- FROST, Roy Anthony
- PUSEY, Darren
- SHARPE, Caroline
- TRANTER, Paul Anthony
- WOLSTENHOLME, Michael
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.09.2017
- Alter der Firma 2017-09-06 8 Jahre
- SIC/NACE
- 22290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Darren Pusey
- -
- Gjb Holdings Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- -
- -
- Ehemalige Namen
- DPPW LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-07-31
- Letzte Einreichung: 2019-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-10-25
- Letzte Einreichung: 2019-09-13
-
LISTERS CENTRAL LIMITED Firmenbeschreibung
- Unit 2 erreicht werden.
Jetzt sichern LISTERS CENTRAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Listers Central Limited - Unit 2, Govan Road, Fenton Industrial Estate, Stoke-On-Trent, Grossbritannien
- 2017-09-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LISTERS CENTRAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-10-30) - AA
-
auditors-resignation-company (2020-01-14) - AUD
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-09-10) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-06-06) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-18) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-18) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-11-12) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-12-04) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-04) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-12-04) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-24) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-24) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-11) - MR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-10-12) - AA01
keyboard_arrow_right 2017
-
incorporation-company (2017-09-06) - NEWINC
-
resolution (2017-09-11) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2017-09-12) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-12) - PSC02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-09-12) - PSC04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-10-13) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-10-19) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-11-11) - MR01