-
TRIB3 INTERNATIONAL LIMITED - Rievaulx House, 1 St Marys Court, York, North Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10870576
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Rievaulx House
- 1 St Marys Court
- York
- North Yorkshire
- YO24 1AH Rievaulx House, 1 St Marys Court, York, North Yorkshire, YO24 1AH UK
Management
- Geschäftsführung
- CERRUTI, Matteo
- FISHER, Allan Brian Henry
- FISHER, Jonathan Marc
- MORAN, Thomas
- YATES, Kevin
- ANGOVE, Kirsty Louise
- BARKER, Robert James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.07.2017
- Alter der Firma 2017-07-18 6 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Tribute Holdings B.V.
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- HLWKH 649 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-02-03
- Letzte Einreichung: 2022-01-20
-
TRIB3 INTERNATIONAL LIMITED Firmenbeschreibung
- TRIB3 INTERNATIONAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10870576. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.07.2017 registriert. TRIB3 INTERNATIONAL LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HLWKH 649 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 7 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Rievaulx House erreicht werden.
Jetzt sichern TRIB3 INTERNATIONAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Trib3 International Limited - Rievaulx House, 1 St Marys Court, York, North Yorkshire, Grossbritannien
- 2017-07-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TRIB3 INTERNATIONAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-03-22) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-01-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-03-01) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-01) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-11-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-17) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-05-19) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-04-07) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-04-07) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-04-08) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-09) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-07) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-23) - AA
-
capital-alter-shares-subdivision (2020-12-19) - SH02
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-17) - AP01
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-07-24) - SH08
-
capital-allotment-shares (2019-07-24) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-23) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-04-23) - PSC01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-27) - AD01
-
resolution (2019-07-25) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-08-07) - AP01
-
resolution (2019-08-19) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-08-19) - SH08
-
capital-allotment-shares (2019-08-20) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2019-11-14) - AA01
-
resolution (2019-07-24) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-04-09) - SH08
-
resolution (2018-04-05) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-27) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-27) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-27) - AP01
-
capital-allotment-shares (2018-03-27) - SH01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-20) - AD01
-
resolution (2017-09-29) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-29) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-29) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-29) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-29) - TM01
-
resolution (2017-08-07) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2017-07-18) - NEWINC