-
100A WANDSWORTH BRIDGE ROAD LTD - Suite 9 Badgemore House, Gravel Hill, Henley On Thames, RG9 4NR, United Kingdom, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10745304
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 9 Badgemore House, Gravel Hill
- Henley On Thames
- RG9 4NR
- United Kingdom Suite 9 Badgemore House, Gravel Hill, Henley On Thames, RG9 4NR, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- PONTIN, Alan
- Prokuristen
- SEARBY, Robert Anthony
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.04.2017
- Alter der Firma 2017-04-28 7 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Alan Henry Pontin
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-01-31
- Letzte Einreichung: 2023-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-11
- Letzte Einreichung: 2023-04-27
-
100A WANDSWORTH BRIDGE ROAD LTD Firmenbeschreibung
- 100A WANDSWORTH BRIDGE ROAD LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10745304. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.04.2017 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Suite 9 Badgemore House, Gravel Hill erreicht werden.
Jetzt sichern 100A WANDSWORTH BRIDGE ROAD LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 100A Wandsworth Bridge Road Ltd - Suite 9 Badgemore House, Gravel Hill, Henley On Thames, RG9 4NR, United Kingdom, Grossbritannien
- 2017-04-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 100A WANDSWORTH BRIDGE ROAD LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-01-16) - AA
-
liquidation-receiver-cease-to-act-receiver (2024-01-26) - RM02
-
liquidation-receiver-abstract-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2024-01-29) - REC2
keyboard_arrow_right 2023
-
liquidation-receiver-abstract-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-11-06) - REC2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-12) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-07-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-24) - CS01
-
liquidation-receiver-abstract-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-05-17) - REC2
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-10-24) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-16) - AA
-
liquidation-receiver-abstract-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-11-29) - REC2
-
liquidation-receiver-abstract-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-05-25) - REC2
-
liquidation-receiver-abstract-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-11-26) - REC2
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-14) - AA
-
liquidation-receiver-abstract-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-11-30) - REC2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-02) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-12) - TM01
-
liquidation-receiver-appointment-of-receiver (2019-10-23) - RM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-26) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-05-02) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-04) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-11) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-02-11) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-02-11) - PSC07
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-02-11) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-11) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-01) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-09) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-26) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-22) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-28) - MR01
-
incorporation-company (2017-04-28) - NEWINC