-
WATERSIDE VILLAGES PROPERTIES LIMITED - 45 Gresham Street, London, EC2V 7BG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10731700
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 45 Gresham Street
- London
- EC2V 7BG 45 Gresham Street, London, EC2V 7BG UK
Management
- Geschäftsführung
- PIKE, Nicholas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.04.2017
- Alter der Firma 2017-04-20 7 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Prime Resort Development Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-03
- Letzte Einreichung: 2023-04-19
-
WATERSIDE VILLAGES PROPERTIES LIMITED Firmenbeschreibung
- WATERSIDE VILLAGES PROPERTIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10731700. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.04.2017 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 45 Gresham Street erreicht werden.
Jetzt sichern WATERSIDE VILLAGES PROPERTIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Waterside Villages Properties Limited - 45 Gresham Street, London, EC2V 7BG, Grossbritannien
- 2017-04-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WATERSIDE VILLAGES PROPERTIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-08-12) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2023-08-12) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2023-08-12) - 600
-
resolution (2023-08-12) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-10-20) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2022-07-12) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-07) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-part (2022-05-19) - MR04
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2022-07-13) - DISS40
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-13) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2021-11-30) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-25) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-02-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-02-10) - AP01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-12-14) - DISS40
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-22) - AP01
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2020-04-21) - AP02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-10) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-03) - AD01
-
resolution (2020-02-21) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-05) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-23) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-04) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-18) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-30) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-29) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-06) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-07) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-03-15) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-24) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-12-20) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2018-12-19) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-02) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-05-16) - PSC02
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-05-16) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-05-16) - PSC07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-21) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-05) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-05-25) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-05-17) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-12) - AP01
-
incorporation-company (2017-04-20) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2017-12-20) - AA01