-
JH BALHAM LTD - 8 Waterloo Court 8 Waterloo Court, 10 Theed Street, London, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10522953
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 8 Waterloo Court 8 Waterloo Court
- 10 Theed Street
- London
- London
- SE1 8ST
- United Kingdom 8 Waterloo Court 8 Waterloo Court, 10 Theed Street, London, London, SE1 8ST, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- HAINES, Stephen Paul
- RAJAH, Joseph Vijayapragash Thiaga
- DIPINO, Paul
- Prokuristen
- HAINES, Stephen Paul
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.12.2016
- Alter der Firma 2016-12-13 7 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Superior Homes Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- CONSORT ROAD LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-14
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
-
JH BALHAM LTD Firmenbeschreibung
- JH BALHAM LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10522953. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.12.2016 registriert. JH BALHAM LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CONSORT ROAD LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 8 Waterloo Court 8 Waterloo Court erreicht werden.
Jetzt sichern JH BALHAM LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jh Balham Ltd - 8 Waterloo Court 8 Waterloo Court, 10 Theed Street, London, Grossbritannien
- 2016-12-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JH BALHAM LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-01-13) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-01-13) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-01-13) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-02-15) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-01-17) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-12-24) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-12-23) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-17) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-09) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-03) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-03) - TM01
-
change-to-a-person-with-significant-control-without-name-date (2019-11-28) - PSC05
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-07-20) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-08-21) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-07-20) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-07-20) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-06-25) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-16) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-16) - PSC02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-11-16) - PSC05
-
change-of-name-notice (2017-06-19) - CONNOT
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-07) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-08) - AP01
-
resolution (2017-06-19) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-24) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-08-04) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-08) - TM01
-
capital-allotment-shares (2017-08-15) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-17) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-18) - AP01
-
resolution (2017-08-25) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-08-25) - SH08
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-09-19) - AP03
-
capital-allotment-shares (2017-11-14) - SH01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-11-14) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-15) - PSC02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-11-15) - PSC05
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-23) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-15) - PSC01
keyboard_arrow_right 2016
-
incorporation-company (2016-12-13) - NEWINC