-
TRAFFORD GARDENS (MANCHESTER) LTD - 60 Oxford Street, Manchester, M1 5EE, United Kingdom, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10513866
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 60 Oxford Street
- Manchester
- M1 5EE
- United Kingdom 60 Oxford Street, Manchester, M1 5EE, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- ALBASSAM, Abdulaziz
- CHOUDHURY, Wasim Wali
- IHSAN, Rofi Miah
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.12.2016
- Alter der Firma 2016-12-07 7 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Beech Holdings Investments Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- CHESTER ROAD (MANCHESTER) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-28
- Letzte Einreichung: 2023-04-14
-
TRAFFORD GARDENS (MANCHESTER) LTD Firmenbeschreibung
- TRAFFORD GARDENS (MANCHESTER) LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10513866. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.12.2016 registriert. TRAFFORD GARDENS (MANCHESTER) LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CHESTER ROAD (MANCHESTER) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 60 Oxford Street erreicht werden.
Jetzt sichern TRAFFORD GARDENS (MANCHESTER) LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Trafford Gardens (Manchester) Ltd - 60 Oxford Street, Manchester, M1 5EE, United Kingdom, Grossbritannien
- 2016-12-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TRAFFORD GARDENS (MANCHESTER) LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-06-03) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-06-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-04-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-04-13) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-04-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-04-28) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2023-05-18) - AA01
-
certificate-change-of-name-company (2023-05-22) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-26) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2021-10-15) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-04-20) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-14) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2021-03-23) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-08-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-08-16) - SH08
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-13) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-03-20) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-26) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-18) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-04) - TM01
-
resolution (2020-08-15) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2020-08-15) - MA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-08-04) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-07-27) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-07-30) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-07-30) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-11) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-23) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-04) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-04) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-12-23) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-allotment-shares (2018-12-19) - SH01
-
resolution (2018-12-19) - RESOLUTIONS
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-12-19) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-18) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2018-11-06) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-09-05) - AA01
-
memorandum-articles (2017-05-12) - MA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-05-05) - MR01
-
resolution (2017-05-12) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
incorporation-company (2016-12-07) - NEWINC