-
GOODMAN LOGISTICS LEICESTER NOMINEE (UK) LIMITED - Cornwall House Blythe Gate, Blythe Valley Park, Solihull, West Midlands, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10475174
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Cornwall House Blythe Gate
- Blythe Valley Park
- Solihull
- West Midlands
- B90 8AF
- United Kingdom Cornwall House Blythe Gate, Blythe Valley Park, Solihull, West Midlands, B90 8AF, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- CORNELL, James Martin
- CROSSLAND, Charles Edward
- HARRIS, Jason Duncan
- REED, Robert Paul
- Prokuristen
- ANCOSEC LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.11.2016
- Alter der Firma 2016-11-11 7 Jahre
- SIC/NACE
- 64305
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Goodman Logistics Leicester (Gp) Llp
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-11-24
- Letzte Einreichung: 2022-11-10
-
GOODMAN LOGISTICS LEICESTER NOMINEE (UK) LIMITED Firmenbeschreibung
- GOODMAN LOGISTICS LEICESTER NOMINEE (UK) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10475174. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.11.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64305" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Cornwall House Blythe Gate erreicht werden.
Jetzt sichern GOODMAN LOGISTICS LEICESTER NOMINEE (UK) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Goodman Logistics Leicester Nominee (Uk) Limited - Cornwall House Blythe Gate, Blythe Valley Park, Solihull, West Midlands, Grossbritannien
- 2016-11-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GOODMAN LOGISTICS LEICESTER NOMINEE (UK) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-01-03) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2023-09-15) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2022-07-20) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-09-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-11-16) - CS01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2021-09-21) - CH04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-07) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-09-21) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-09-21) - PSC05
keyboard_arrow_right 2020
-
memorandum-articles (2020-10-16) - MA
-
resolution (2020-10-16) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-11-24) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-09-10) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-08-08) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-18) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-17) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-01-31) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-10-02) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-12-28) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-21) - AP01
-
incorporation-company (2016-11-11) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-21) - TM01