-
CULTURE WINS LIMITED - Unit 16 Leigh Road, Haine Industrial Estate, Ramsgate, Kent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10462733
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 16 Leigh Road
- Haine Industrial Estate
- Ramsgate
- Kent
- CT12 5EU
- England Unit 16 Leigh Road, Haine Industrial Estate, Ramsgate, Kent, CT12 5EU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ASHTON, Harry
- HARRIS, David Douglas
- HOLLOWAY, Andrew David
- HYNES, Martin Paul
- JOHNS, Gareth
- JOHNS, Samantha Jane
- LLEWELLYN, Joanne Sarah
- MURPHY, Jessica
- HUTTON, Lee Aaron
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.11.2016
- Alter der Firma 2016-11-04 7 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-21
- Letzte Einreichung: 2020-06-07
-
CULTURE WINS LIMITED Firmenbeschreibung
- CULTURE WINS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10462733. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.11.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 9 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 16 Leigh Road erreicht werden.
Jetzt sichern CULTURE WINS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Culture Wins Limited - Unit 16 Leigh Road, Haine Industrial Estate, Ramsgate, Kent, Grossbritannien
- 2016-11-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CULTURE WINS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-06-16) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-06-17) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-12-22) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-16) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-06-16) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-02) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-04) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-01) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-18) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-06-18) - PSC08
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-06-17) - PSC07
-
resolution (2019-04-11) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-04-09) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-04) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-07) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-04-04) - MR04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-03-11) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-03-11) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-06-15) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-08) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-08) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-01-23) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-01-25) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-10) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-05-21) - CH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-05-22) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-allotment-shares (2017-06-07) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-05-31) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-24) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-07-13) - MR01
-
capital-alter-shares-consolidation (2017-07-10) - SH02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
incorporation-company (2016-11-04) - NEWINC