-
-
CAPITAL Q CARDIFF CONSTRUCTION LIMITED - 35 Ballards Lane, London, N3 1XW, United Kingdom, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10444737
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 35 Ballards Lane
- London
- N3 1XW
- United Kingdom 35 Ballards Lane, London, N3 1XW, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BEVAN, Michael Stephen
- MILES, Paul
- OSEN, Gideon Paul
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.10.2016
- Gelöscht am:
- 2022-09-20
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Nigel John Henry
- Mr Warren Phillip Rosenberg
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- -
- -
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-05-31
- Letzte Einreichung: 2020-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-11-07
- Letzte Einreichung: 2021-10-24
-
CAPITAL Q CARDIFF CONSTRUCTION LIMITED Firmenbeschreibung
- 35 Ballards Lane erreicht werden.
Jetzt sichern CAPITAL Q CARDIFF CONSTRUCTION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Capital Q Cardiff Construction Limited - 35 Ballards Lane, London, N3 1XW, United Kingdom, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CAPITAL Q CARDIFF CONSTRUCTION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-01-20) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-06) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-06-25) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-26) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-11-02) - PSC04
-
resolution (2020-09-07) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2020-09-05) - SH02
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-08-26) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-08-26) - PSC07
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-08-27) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-01-06) - CH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-04-17) - MR04
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-05-27) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-23) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2019-05-16) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-23) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-16) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-06-19) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-07-18) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2017-07-18) - MA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-26) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-11-17) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
incorporation-company (2016-10-25) - NEWINC