-
DENSE AIR LIMITED - Atlas House Globe Business Park, Third Avenue, Marlow, Buckinghamshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10402747
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Atlas House Globe Business Park
- Third Avenue
- Marlow
- Buckinghamshire
- SL7 1EY
- United Kingdom Atlas House Globe Business Park, Third Avenue, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1EY, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- SENIOR, Paul Nicholas
- CURRIER, Graham Alan
- ESTES, James Ronald
- LEE, Douglass B
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.09.2016
- Alter der Firma 2016-09-29 7 Jahre
- SIC/NACE
- 61200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- AIRSPAN SPECTRUM HOLDINGS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-06
- Letzte Einreichung: 2023-03-23
-
DENSE AIR LIMITED Firmenbeschreibung
- DENSE AIR LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10402747. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.09.2016 registriert. DENSE AIR LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen AIRSPAN SPECTRUM HOLDINGS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "61200" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Atlas House Globe Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern DENSE AIR LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dense Air Limited - Atlas House Globe Business Park, Third Avenue, Marlow, Buckinghamshire, Grossbritannien
- 2016-09-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DENSE AIR LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-group (2024-02-14) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-06-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-06-13) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2023-01-04) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-10-12) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-12-09) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-08-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-08-12) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2022-03-11) - PSC08
-
confirmation-statement-with-updates (2022-04-08) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-03-11) - PSC07
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2022-03-11) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-03-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-03-11) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-03-11) - TM02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-01-06) - MR01
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-charge-part-both-with-charge-number (2021-03-02) - MR05
-
mortgage-charge-part-release-with-charge-number (2021-03-02) - MR05
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2021-03-09) - SH10
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-12-10) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-03-22) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-01-12) - AA
-
resolution (2021-03-12) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-07) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-08-25) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-09-17) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-06-29) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-09) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-06-05) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-10-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-27) - CS01
-
second-filing-capital-allotment-shares (2019-08-07) - RP04SH01
-
legacy (2019-08-07) - RP04CS01
-
capital-allotment-shares (2019-08-20) - SH01
-
resolution (2019-08-21) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-07-04) - AA
-
change-of-name-notice (2018-07-25) - CONNOT
-
resolution (2018-07-25) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-allotment-shares (2017-01-25) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-27) - TM01
-
resolution (2017-03-07) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-31) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-27) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-01-25) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-10-25) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-24) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-10-21) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-20) - AP01
-
incorporation-company (2016-09-29) - NEWINC