-
PRODO TECH LTD - 4 Mount Ephraim Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 1EE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10307470
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4 Mount Ephraim Road
- Tunbridge Wells
- Kent
- TN1 1EE 4 Mount Ephraim Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 1EE UK
Management
- Geschäftsführung
- DAWES, Thomas Charles
- HARRIS, F Hadley
- MARNETTE, Bruno, Dr
- VISVANATHAN, Krishna
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.08.2016
- Gelöscht am:
- 2022-02-01
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-05-31
- Letzte Einreichung: 2019-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-09-12
- Letzte Einreichung: 2019-08-01
-
PRODO TECH LTD Firmenbeschreibung
- PRODO TECH LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10307470. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 02.08.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.08.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 4 Mount Ephraim Road erreicht werden.
Jetzt sichern PRODO TECH LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Prodo Tech Ltd - 4 Mount Ephraim Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 1EE, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PRODO TECH LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-death-liquidator (2021-08-20) - LIQ09
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-08-23) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-08-23) - 600
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-08-10) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-07-02) - AD01
-
change-sail-address-company-with-old-address-new-address (2020-06-30) - AD02
-
resolution (2020-06-29) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-07-03) - 600
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-07-03) - LIQ01
keyboard_arrow_right 2019
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-08-07) - PSC09
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-05) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-08-27) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2019-08-27) - SH10
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-13) - CS01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-08-12) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-08-12) - PSC08
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-08-12) - PSC01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-08-07) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-15) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-08-16) - PSC08
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-16) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-08-10) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-16) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-22) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-14) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-01) - TM01
-
resolution (2018-05-01) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-30) - AP01
-
change-sail-address-company-with-old-address-new-address (2018-04-06) - AD02
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2018-04-05) - AD03
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-16) - PSC07
-
directors-register-information-on-withdrawal-from-the-public-register (2018-02-28) - EW01RSS
-
withdrawal-of-the-directors-residential-address-register-information-from-the-public-register (2018-02-28) - EW02
-
withdrawal-of-the-directors-register-information-from-the-public-register (2018-02-28) - EW01
-
capital-allotment-shares (2018-05-10) - SH01
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-01-17) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2017-01-19) - SH02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-30) - AP01
-
resolution (2017-02-17) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-30) - AP01
-
capital-allotment-shares (2016-12-01) - SH01
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2016-11-29) - AD03
-
change-sail-address-company-with-new-address (2016-11-29) - AD02
-
incorporation-company (2016-08-02) - NEWINC
-
resolution (2016-12-30) - RESOLUTIONS