-
WHC01 LIMITED - Suite A, Fernbank House Springwood Way, Tytherington Business Park, Macclesfield, SK10 2XA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10292972
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite A, Fernbank House Springwood Way
- Tytherington Business Park
- Macclesfield
- SK10 2XA
- England Suite A, Fernbank House Springwood Way, Tytherington Business Park, Macclesfield, SK10 2XA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- LINDSAY, Jacqueline Ann
- OGDEN, Neil Joseph
- Prokuristen
- OGDEN, Neil Joseph
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.07.2016
- Alter der Firma 2016-07-25 7 Jahre
- SIC/NACE
- 78109
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Andrew Healing
- Key Capital Partners Limited
- -
- -
- Project Sirius Bidco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-08-07
- Letzte Einreichung: 2021-07-24
-
WHC01 LIMITED Firmenbeschreibung
- WHC01 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10292972. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.07.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "78109" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Suite A, Fernbank House Springwood Way erreicht werden.
Jetzt sichern WHC01 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Whc01 Limited - Suite A, Fernbank House Springwood Way, Tytherington Business Park, Macclesfield, SK10 2XA, Grossbritannien
- 2016-07-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WHC01 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-06-15) - MR01
-
second-filing-notification-of-a-person-with-significant-control (2021-03-18) - RP04PSC02
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-06-09) - AA
-
resolution (2021-03-25) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2021-03-25) - MA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-08-26) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-08-13) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-08-13) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-08-13) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-08-13) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2021-08-13) - AP03
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-01-20) - PSC04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-08-13) - TM02
-
memorandum-articles (2021-06-28) - MA
-
resolution (2021-06-28) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-06-21) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-06-18) - MR01
-
legacy (2021-06-17) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2021-06-17) - SH19
-
legacy (2021-06-17) - CAP-SS
-
resolution (2021-06-17) - RESOLUTIONS
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-02-05) - PSC04
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-09-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
capital-allotment-shares (2019-08-28) - SH01
-
resolution (2019-08-15) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-08-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-26) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-20) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-01-02) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-07-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-01) - CS01
-
capital-cancellation-shares (2018-04-16) - SH06
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-26) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-11-26) - AP03
-
capital-return-purchase-own-shares (2018-04-16) - SH03
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-01-13) - AA01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-25) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-26) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-01) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-10-02) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
incorporation-company (2016-07-25) - NEWINC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-16) - AD01
-
capital-allotment-shares (2016-12-05) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-20) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-23) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-19) - AP01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2016-08-19) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-08-19) - SH08
-
capital-allotment-shares (2016-08-19) - SH01
-
resolution (2016-08-19) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2016-12-30) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-08-08) - MR01