-
ALPHA HOLIDAYS LIMITED - C/O Edge Recovery Limited 5-7, Ravensbourne Road, Bromley, BR1 1HN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10270092
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Edge Recovery Limited 5-7
- Ravensbourne Road
- Bromley
- BR1 1HN C/O Edge Recovery Limited 5-7, Ravensbourne Road, Bromley, BR1 1HN UK
Management
- Geschäftsführung
- EDARA, Sridhar Kumar
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.07.2016
- Alter der Firma 2016-07-08 7 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Truly Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- B2C NEWCO LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 2138007E6LO5NCYRKA59
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-01-31
- Letzte Einreichung: 2019-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2016-12-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-11-04
- Letzte Einreichung: 2021-10-21
-
ALPHA HOLIDAYS LIMITED Firmenbeschreibung
- ALPHA HOLIDAYS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10270092. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.07.2016 registriert. ALPHA HOLIDAYS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen B2C NEWCO LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.12.2016.Die Firma kann schriftlich über C/o Edge Recovery Limited 5-7 erreicht werden.
Jetzt sichern ALPHA HOLIDAYS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Alpha Holidays Limited - C/O Edge Recovery Limited 5-7, Ravensbourne Road, Bromley, BR1 1HN, Grossbritannien
- 2016-07-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ALPHA HOLIDAYS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-02-06) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-12-15) - 600
-
resolution (2021-12-08) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2021-12-08) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-12-08) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2021-07-20) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-21) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-10-22) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-05-10) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
memorandum-articles (2020-01-15) - MA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-30) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-21) - CS01
-
legacy (2020-02-19) - RP04CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-10-14) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
legacy (2019-12-01) - RP04CS01
-
resolution (2019-12-09) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-10-25) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-03-13) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-19) - TM01
-
confirmation-statement (2019-10-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2018-09-14) - CH04
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-03-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-28) - AD01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2018-03-27) - AP04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-20) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-02-01) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-17) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-24) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-22) - CS01
-
legacy (2017-09-13) - RP04CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
legacy (2016-12-21) - CS01
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-12-01) - SH02
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-11-08) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2016-11-08) - SH10
-
capital-allotment-shares (2016-11-08) - SH01
-
resolution (2016-11-08) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-24) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-21) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-21) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-10-21) - AA01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2016-10-20) - SH19
-
legacy (2016-10-20) - SH20
-
legacy (2016-10-20) - CAP-SS
-
resolution (2016-10-20) - RESOLUTIONS
-
resolution (2016-08-02) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2016-08-02) - CONNOT
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-07-14) - AD01
-
incorporation-company (2016-07-08) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-31) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-10-07) - MR01