-
ANEXSYS GROUP LIMITED - The Space, 41 Old Street, London, EC1V 9AE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10268613
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Space
- 41 Old Street
- London
- EC1V 9AE
- England The Space, 41 Old Street, London, EC1V 9AE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MORAN, David
- MORTENSEN, Kathryn
- POWLEN, Brooks
- RODRIGUEZ, Frank
- VAN SPAENDONCK, Gerardus
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.07.2016
- Alter der Firma 2016-07-08 7 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- HOBS GROUP LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-30
- Letzte Einreichung: 2019-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-21
- Letzte Einreichung: 2020-07-07
-
ANEXSYS GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- ANEXSYS GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10268613. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.07.2016 registriert. ANEXSYS GROUP LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HOBS GROUP LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über The Space erreicht werden.
Jetzt sichern ANEXSYS GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Anexsys Group Limited - The Space, 41 Old Street, London, EC1V 9AE, Grossbritannien
- 2016-07-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ANEXSYS GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-08-22) - SH08
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-01-13) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-08-10) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-10) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-08-12) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2020-08-12) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-12) - AP01
-
resolution (2020-08-13) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-08-14) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-08-18) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2020-08-18) - PSC08
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-01-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-25) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-13) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-05-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-10) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-10) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-10) - PSC02
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-07) - PSC02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-07) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-13) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-13) - TM01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-07-13) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-13) - PSC01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-07-14) - AA01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-07-14) - PSC07
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-09-13) - MR01
-
change-of-name-notice (2017-09-15) - CONNOT
-
resolution (2017-09-15) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-21) - AP01
-
resolution (2017-09-22) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-22) - AP01
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-09-22) - SH08
-
capital-allotment-shares (2017-09-25) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-07-14) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
incorporation-company (2016-07-08) - NEWINC