-
DELAMIN NITRIDING SALTS LIMITED - 4 Mount Ephraim Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 1EE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10254764
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4 Mount Ephraim Road
- Tunbridge Wells
- Kent
- TN1 1EE 4 Mount Ephraim Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 1EE UK
Management
- Geschäftsführung
- GRINSTEAD, Billy Michael
- KROMALIC, Joseph Jay
- SATOMI, Nobuhiko
- WHALEY, Phil Dean
- Prokuristen
- GRINSTEAD, Billy Michael
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.06.2016
- Gelöscht am:
- 2024-02-08
- SIC/NACE
- 20590
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Nihon Parkerizing Co., Ltd.
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- CASTLEGATE 754 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-08-08
- Letzte Einreichung: 2019-06-27
-
DELAMIN NITRIDING SALTS LIMITED Firmenbeschreibung
- DELAMIN NITRIDING SALTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10254764. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 28.06.2016 registriert. DELAMIN NITRIDING SALTS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CASTLEGATE 754 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "20590" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 4 Mount Ephraim Road erreicht werden.
Jetzt sichern DELAMIN NITRIDING SALTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Delamin Nitriding Salts Limited - 4 Mount Ephraim Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 1EE, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DELAMIN NITRIDING SALTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-death-liquidator (2021-08-20) - LIQ09
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-08-20) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-08-17) - LIQ03
-
change-sail-address-company-with-new-address (2021-02-04) - AD02
keyboard_arrow_right 2020
-
resolution (2020-07-10) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-07-10) - LIQ01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-04-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-15) - TM01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-07-10) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-07-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-21) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-21) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-01-21) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-01-21) - AP03
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-02-07) - PSC07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-21) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-02-07) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-11) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-15) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-03-21) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-03-29) - AA
-
capital-cancellation-shares (2018-01-12) - SH06
-
resolution (2018-01-12) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-21) - PSC01
-
capital-return-purchase-own-shares (2018-01-12) - SH03
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-06) - TM01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2017-10-20) - SH19
-
legacy (2017-10-20) - CAP-SS
-
resolution (2017-10-20) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-09-27) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-09-04) - AA01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-27) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-11) - CS01
-
legacy (2017-10-20) - SH20
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-03) - AP01
-
incorporation-company (2016-06-28) - NEWINC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-08-03) - AD01
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-08-23) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2016-08-23) - SH10
-
resolution (2016-08-24) - RESOLUTIONS
-
legacy (2016-10-13) - CAP-SS
-
capital-allotment-shares (2016-09-01) - SH01
-
resolution (2016-10-13) - RESOLUTIONS
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2016-10-13) - SH19
-
legacy (2016-10-13) - SH20
-
change-of-name-notice (2016-12-13) - CONNOT
-
resolution (2016-12-13) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-08-03) - AP03
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-08-31) - SH02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-03) - TM01