-
FRAMEWORK BREWERY LIMITED - Cba Business Solutions Ltd, 126 New Walk, Leicester, LE1 7JA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10240811
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Cba Business Solutions Ltd
- 126 New Walk
- Leicester
- LE1 7JA Cba Business Solutions Ltd, 126 New Walk, Leicester, LE1 7JA UK
Management
- Geschäftsführung
- MABE, Matthew Philip
- OWEN, Richard John
- WILLIS, James Thomas
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.06.2016
- Gelöscht am:
- 2024-05-16
- SIC/NACE
- 11050
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Bulb Studios Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-03-31
- Letzte Einreichung: 2021-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-10-18
- Letzte Einreichung: 2021-10-04
-
FRAMEWORK BREWERY LIMITED Firmenbeschreibung
- FRAMEWORK BREWERY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10240811. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 20.06.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "11050" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Cba Business Solutions Ltd erreicht werden.
Jetzt sichern FRAMEWORK BREWERY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Framework Brewery Limited - Cba Business Solutions Ltd, 126 New Walk, Leicester, LE1 7JA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FRAMEWORK BREWERY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-dissolved-liquidation (2024-05-16) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2024-02-16) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2022
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2022-03-31) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-06-29) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-06-29) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-14) - AA
-
resolution (2022-12-21) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-12-21) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2022-12-21) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-12-21) - AD01
-
gazette-notice-compulsory (2022-12-27) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-09) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-16) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-10) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-17) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-08) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-07) - TM01
-
capital-allotment-shares (2018-01-10) - SH01
-
capital-allotment-shares (2018-10-30) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-13) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-13) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-22) - AR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-29) - CS01
-
incorporation-company (2016-06-20) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2016-10-11) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-06-22) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-22) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-14) - CS01