-
MERCIA POWER RESPONSE (ASHER LANE 2) LIMITED - Strelley Hall Main Street, Strelley, Nottingham, NG8 6PE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10217188
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Strelley Hall Main Street
- Strelley
- Nottingham
- NG8 6PE
- United Kingdom Strelley Hall Main Street, Strelley, Nottingham, NG8 6PE, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- O'BRIEN, Neil Christopher
- SHAW, Graham Ernest
- TITTLEY, Paul
- WHITE, Graham Edward
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.06.2016
- Alter der Firma 2016-06-06 8 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Frp Mercia Holdco Limited
- Mercia Power Response Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- MERCIA POWER RESPONSE (GRAPHITE WAY) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-15
- Letzte Einreichung: 2021-06-01
-
MERCIA POWER RESPONSE (ASHER LANE 2) LIMITED Firmenbeschreibung
- MERCIA POWER RESPONSE (ASHER LANE 2) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10217188. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.06.2016 registriert. MERCIA POWER RESPONSE (ASHER LANE 2) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MERCIA POWER RESPONSE (GRAPHITE WAY) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Strelley Hall Main Street erreicht werden.
Jetzt sichern MERCIA POWER RESPONSE (ASHER LANE 2) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mercia Power Response (Asher Lane 2) Limited - Strelley Hall Main Street, Strelley, Nottingham, NG8 6PE, Grossbritannien
- 2016-06-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MERCIA POWER RESPONSE (ASHER LANE 2) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
legacy (2021-09-16) - AGREEMENT2
-
legacy (2021-09-16) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-15) - CS01
-
memorandum-articles (2021-06-12) - MA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-05-26) - MR01
-
resolution (2021-06-12) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-03-11) - MR04
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-05-19) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
legacy (2020-11-12) - GUARANTEE2
-
legacy (2020-11-12) - AGREEMENT2
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-10-20) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-01) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-01-10) - CH01
-
legacy (2020-11-12) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-11-12) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-12-09) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-24) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-24) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-20) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-10) - AP01
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2018-12-10) - AP02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-12) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-08-16) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-02) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-12-10) - AP03
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-21) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-21) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-30) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-21) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-21) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2017-11-09) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-11-09) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-11-09) - AA01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-21) - PSC02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-08-21) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-08-21) - TM02
keyboard_arrow_right 2016
-
certificate-change-of-name-company (2016-07-04) - CERTNM
-
incorporation-company (2016-06-06) - NEWINC