-
NORTH WEST BIOMASS LIMITED - Suite 3, Regency House, 91 Western Road, Brighton, BN1 2NW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10188625
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 3, Regency House
- 91 Western Road
- Brighton
- BN1 2NW Suite 3, Regency House, 91 Western Road, Brighton, BN1 2NW UK
Management
- Geschäftsführung
- DAVIES, Philip John
- MILLS, Peter
- ROSS, Nicholas Robert William
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.05.2016
- Alter der Firma 2016-05-19 8 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Iona Environmental Infrastructure 2 Lp
- Iona North West Environmental Infrastructure Lp
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- In Administration
- Ehemalige Namen
- NEWBRIDGE ENERGY (TIR LLWYD) LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-06-01
- Letzte Einreichung: 2022-05-18
-
NORTH WEST BIOMASS LIMITED Firmenbeschreibung
- NORTH WEST BIOMASS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10188625. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.05.2016 registriert. NORTH WEST BIOMASS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen NEWBRIDGE ENERGY (TIR LLWYD) LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Suite 3, Regency House erreicht werden.
Jetzt sichern NORTH WEST BIOMASS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: North West Biomass Limited - Suite 3, Regency House, 91 Western Road, Brighton, BN1 2NW, Grossbritannien
- 2016-05-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NORTH WEST BIOMASS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-in-administration-progress-report (2023-09-15) - AM10
-
liquidation-in-administration-progress-report (2023-03-22) - AM10
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2023-08-04) - AM19
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2022-09-15) - AM06
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2022-10-26) - AM02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-03-28) - PSC05
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-05-25) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-01-05) - AA
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2022-08-22) - AM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-08-22) - AD01
-
liquidation-in-administration-proposals (2022-08-30) - AM03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-18) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-06-09) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2021-06-08) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-03) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-02-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-01-27) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-01-21) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-01-21) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2021-11-26) - AA01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-12-23) - AA
-
legacy (2019-02-07) - RP04CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-12-21) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-28) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-30) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-05) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-09) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-01) - CS01
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-10-23) - SH08
-
resolution (2017-10-20) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-08-30) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-08-02) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2016-08-02) - SH10
-
resolution (2016-08-01) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-07-13) - MR01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-07-12) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-12) - AP01
-
resolution (2016-06-21) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2016-05-19) - NEWINC