-
NYX DIGITAL GAMING (BETDIGITAL HOLDINGS) LIMITED - Fourth Floor Building 9 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5XT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10156770
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Fourth Floor Building 9 Chiswick Park
- 566 Chiswick High Road
- London
- W4 5XT Fourth Floor Building 9 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5XT UK
Management
- Geschäftsführung
- BENGTSON, Melissa Autumn Braff
- JAMES, Constance Purcell
- Prokuristen
- BENGTSON, Melissa Autumn Braff
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.04.2016
- Gelöscht am:
- 2023-06-27
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Scientific Games Corporation
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- SNRDCO 3231 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-12
- Letzte Einreichung: 2021-04-28
-
NYX DIGITAL GAMING (BETDIGITAL HOLDINGS) LIMITED Firmenbeschreibung
- NYX DIGITAL GAMING (BETDIGITAL HOLDINGS) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10156770. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 29.04.2016 registriert. NYX DIGITAL GAMING (BETDIGITAL HOLDINGS) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SNRDCO 3231 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Fourth Floor Building 9 Chiswick Park erreicht werden.
Jetzt sichern NYX DIGITAL GAMING (BETDIGITAL HOLDINGS) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Nyx Digital Gaming (Betdigital Holdings) Limited - Fourth Floor Building 9 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5XT, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NYX DIGITAL GAMING (BETDIGITAL HOLDINGS) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-11-11) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-11-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-29) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-11-08) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2021-11-08) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-11-08) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-11-08) - TM02
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-07-03) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-03) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-30) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-01-04) - DISS40
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-07-03) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-07-03) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-07-09) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-03) - GAZ1
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-25) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-25) - PSC02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-02-12) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-01-05) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-13) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-16) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-22) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-03-21) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-21) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-03-21) - TM02
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-12-21) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-11-29) - DISS40
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-05) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-11) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-06) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-04-06) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-05) - TM01
-
gazette-notice-compulsory (2017-11-28) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-25) - TM01
-
incorporation-company (2016-04-29) - NEWINC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-24) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-05-24) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-25) - AP01
-
resolution (2016-05-31) - RESOLUTIONS
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-09-05) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-09-05) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-05) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-09-05) - AA01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-05-24) - AP03
-
resolution (2016-05-24) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-06-28) - MR01