-
BLACK COUNTRY ROCK LIMITED - Office D Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10120219
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Office D Beresford House
- Town Quay
- Southampton
- SO14 2AQ Office D Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ UK
Management
- Geschäftsführung
- BRIDGER, Simon John
- CAMPBELL, Christopher
- EMMERSON, Philip Raymond
- GOLD ROUND LIMITED
- Prokuristen
- RJP SECRETARIES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.04.2016
- Gelöscht am:
- 2022-05-25
- SIC/NACE
- 74990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Hay Wain Group Limited
- Gold Round Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- SPLASH NEWS AND PICTURE GROUP LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800O81537IHSI3S46
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-10-31
- Letzte Einreichung: 2018-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-25
- Letzte Einreichung: 2020-04-11
-
BLACK COUNTRY ROCK LIMITED Firmenbeschreibung
- BLACK COUNTRY ROCK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10120219. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 12.04.2016 registriert. BLACK COUNTRY ROCK LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SPLASH NEWS AND PICTURE GROUP LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74990" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Office D Beresford House erreicht werden.
Jetzt sichern BLACK COUNTRY ROCK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Black Country Rock Limited - Office D Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BLACK COUNTRY ROCK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2021-03-17) - AM01
-
liquidation-in-administration-proposals (2021-04-29) - AM03
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2021-05-18) - AM06
-
mortgage-charge-part-both-with-charge-number (2021-03-10) - MR05
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-03-12) - AD01
-
gazette-notice-compulsory (2021-01-05) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-01-23) - DISS40
-
mortgage-charge-part-both-with-charge-number (2021-02-06) - MR05
-
resolution (2021-02-19) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-30) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-04-24) - PSC02
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2020-01-17) - AA01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-06-30) - PSC05
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-07-09) - SH08
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-08-12) - PSC05
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-20) - TM01
-
change-person-director-company (2019-09-26) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-09-25) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-09-18) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-05) - TM01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2019-08-12) - CH04
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-24) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-03-27) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-22) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-25) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-10-15) - CH01
-
second-filing-capital-allotment-shares (2018-09-04) - RP04SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-11-15) - CH01
-
resolution (2018-08-23) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2018-07-02) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-06-26) - MR01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-24) - PSC07
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-07-10) - SH08
-
resolution (2018-07-06) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2018-06-29) - SH01
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2018-06-28) - AP02
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-07-24) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-17) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-12) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-20) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-07-20) - PSC07
-
memorandum-articles (2017-04-20) - MA
-
resolution (2017-04-20) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-12-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-09-29) - CH01
-
incorporation-company (2016-04-12) - NEWINC