-
SIGNATURE VICTORIA MILL LIMITED - C/O FRP ADVISORY TRADING LIMITED, Derby House 12 Winckley Square, Preston, PR1 3JJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10099833
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O FRP ADVISORY TRADING LIMITED
- Derby House 12 Winckley Square
- Preston
- PR1 3JJ C/O FRP ADVISORY TRADING LIMITED, Derby House 12 Winckley Square, Preston, PR1 3JJ UK
Management
- Geschäftsführung
- KENWRIGHT, Lawrence
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.04.2016
- Alter der Firma 2016-04-04 8 Jahre
- SIC/NACE
- 55900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Lawrence Kenwright
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- In Administration
- Ehemalige Namen
- SIGNATURE IMPORTS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-06-30
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-05-03
- Letzte Einreichung: 2020-04-19
-
SIGNATURE VICTORIA MILL LIMITED Firmenbeschreibung
- SIGNATURE VICTORIA MILL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10099833. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.04.2016 registriert. SIGNATURE VICTORIA MILL LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SIGNATURE IMPORTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "55900" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Frp Advisory Trading Limited erreicht werden.
Jetzt sichern SIGNATURE VICTORIA MILL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Signature Victoria Mill Limited - C/O FRP ADVISORY TRADING LIMITED, Derby House 12 Winckley Square, Preston, PR1 3JJ, Grossbritannien
- 2016-04-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SIGNATURE VICTORIA MILL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-in-administration-progress-report (2023-05-20) - AM10
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-in-administration-progress-report (2022-05-17) - AM10
-
liquidation-in-administration-progress-report (2022-11-14) - AM10
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-in-administration-progress-report (2021-11-17) - AM10
-
court-order (2021-04-14) - OC
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2021-04-26) - AM19
-
liquidation-in-administration-progress-report (2021-06-01) - AM10
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-19) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-04-19) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-04-19) - PSC07
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-03-31) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-04-24) - AD01
-
liquidation-in-administration-proposals (2020-06-17) - AM03
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2020-05-01) - AM01
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2020-07-07) - AM06
-
(2020-11-19) - ANNOTATION
-
liquidation-in-administration-progress-report (2020-11-28) - AM10
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-05-14) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-05-14) - PSC02
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-05-08) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-28) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-08) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-05-08) - PSC02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-03) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-08-20) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-13) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-07-03) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-12-21) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-13) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-07-05) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-07-03) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-25) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-06-18) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-05-02) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-07-03) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-31) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-12) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-01-11) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-11-23) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-11-07) - MR01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-10-25) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-25) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-20) - CS01
-
incorporation-company (2016-04-04) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-20) - TM01