-
SOUTHERN COMMUNICATIONS GROUP LIMITED - Glebe Farm, Down Street, Dummer, Hampshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10053004
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Glebe Farm
- Down Street
- Dummer
- Hampshire
- RG25 2AD
- England Glebe Farm, Down Street, Dummer, Hampshire, RG25 2AD, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BRADFORD, Paul James
- GOLDIE, David Carruth
- KIRK, Mathew Owen
- PHILLIPS, David Charles
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.03.2016
- Alter der Firma 2016-03-09 8 Jahre
- SIC/NACE
- 61900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Saint Bidco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-25
- Letzte Einreichung: 2023-06-11
-
SOUTHERN COMMUNICATIONS GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- SOUTHERN COMMUNICATIONS GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10053004. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.03.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "61900" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Glebe Farm erreicht werden.
Jetzt sichern SOUTHERN COMMUNICATIONS GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Southern Communications Group Limited - Glebe Farm, Down Street, Dummer, Hampshire, Grossbritannien
- 2016-03-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SOUTHERN COMMUNICATIONS GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-13) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-group (2023-01-17) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-group (2023-01-13) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-12-01) - AP01
-
memorandum-articles (2022-01-14) - MA
-
resolution (2022-01-14) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-01-12) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-07-18) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-01-12) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-01-12) - PSC07
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-12-22) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-12-20) - MR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-09-01) - DISS40
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-26) - CH01
-
gazette-notice-compulsory (2021-08-31) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-01-12) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-09-28) - CH01
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2020-10-12) - RP04CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-29) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-12-17) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-23) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-23) - PSC07
-
confirmation-statement (2019-06-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-allotment-shares (2018-04-19) - SH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-09-04) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-08-24) - MR01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-08-15) - PSC04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-08-15) - PSC05
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-09-24) - SH08
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-04-17) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-12) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-03) - CS01
-
resolution (2018-03-26) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2018-09-12) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-09) - TM01
-
capital-alter-shares-subdivision (2018-11-02) - SH02
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-12-10) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-03-27) - SH08
-
resolution (2018-09-21) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-10-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-05-18) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-18) - AP01
-
incorporation-company (2016-03-09) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-02) - AP01
-
capital-allotment-shares (2016-10-17) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-06-09) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2016-06-09) - SH10
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-06) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-03) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-06-02) - TM02
-
resolution (2016-06-08) - RESOLUTIONS