-
LYE GREEN DEVELOPMENT LIMITED - 17 Partridge Road, St. Albans, AL3 6HH, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10038416
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 17 Partridge Road
- St. Albans
- AL3 6HH
- England 17 Partridge Road, St. Albans, AL3 6HH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GREWAL, Amardeep Singh
- KARIR, Maninder Singh
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.03.2016
- Alter der Firma 2016-03-02 8 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Ricky Anthony Levenston
- Mr Amardeep Singh Grewal
- -
- Mr Maninder Singh Karir
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-05-31
- Letzte Einreichung: 2023-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-12-27
- Letzte Einreichung: 2023-12-13
-
LYE GREEN DEVELOPMENT LIMITED Firmenbeschreibung
- LYE GREEN DEVELOPMENT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10038416. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.03.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.08.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 17 Partridge Road erreicht werden.
Jetzt sichern LYE GREEN DEVELOPMENT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Lye Green Development Limited - 17 Partridge Road, St. Albans, AL3 6HH, England, Grossbritannien
- 2016-03-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LYE GREEN DEVELOPMENT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2024-04-16) - MR01
keyboard_arrow_right 2023
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-08-30) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-09-07) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-09-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-11-21) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2023-12-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-08-26) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-10-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-11-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-09-14) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-16) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-03-16) - PSC07
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-07-29) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-09-17) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-09) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-09-11) - AA
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-05-02) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-04) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-21) - CS01
-
capital-allotment-shares (2018-11-21) - SH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-03-05) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-08-03) - PSC04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-03) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-10-09) - AA
-
resolution (2017-06-01) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-11-15) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-11-14) - MR01
-
capital-alter-shares-subdivision (2017-06-08) - SH02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-22) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-05-22) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-22) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-05-22) - AD01
-
legacy (2017-05-16) - RP04CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-03-20) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-15) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-05-23) - MR04
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2016-03-24) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-03-24) - SH08
-
resolution (2016-03-24) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-23) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-08) - AP01
-
incorporation-company (2016-03-02) - NEWINC