-
POWER TOPCO LIMITED - Roundhouse Road, Faverdale Industrial Estate, Darlington, County Durham, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10037838
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Roundhouse Road
- Faverdale Industrial Estate
- Darlington
- County Durham
- DL3 0UR
- England Roundhouse Road, Faverdale Industrial Estate, Darlington, County Durham, DL3 0UR, England UK
Management
- Geschäftsführung
- AINSCOUGH, Tom
- BROWNING, James Scott
- CALVESBERT, Ian James
- GIBSON, Paul
- BUSHELL, Benjamin Charles
- HAYCOCK, Robert Owen
- SHERWOOD, Jonathan Frank
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.03.2016
- Alter der Firma 2016-03-02 8 Jahre
- SIC/NACE
- 46690
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Project Polka Bidco Limited
- -
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-15
- Letzte Einreichung: 2021-03-01
-
POWER TOPCO LIMITED Firmenbeschreibung
- POWER TOPCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10037838. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.03.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46690" registriert. Das Unternehmen hat 7 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Roundhouse Road erreicht werden.
Jetzt sichern POWER TOPCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Power Topco Limited - Roundhouse Road, Faverdale Industrial Estate, Darlington, County Durham, Grossbritannien
- 2016-03-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu POWER TOPCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-12) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-01-28) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-07-09) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-02-24) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-07-07) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-12) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2019-12-24) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-09-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-12) - CS01
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2019-02-25) - AD03
-
change-sail-address-company-with-new-address (2019-02-25) - AD02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-01-10) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
memorandum-articles (2018-01-03) - MA
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2018-01-03) - SH10
-
resolution (2018-01-04) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-01-03) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2018-01-08) - SH10
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-09-24) - AA
-
capital-alter-shares-consolidation-subdivision (2018-01-05) - SH02
keyboard_arrow_right 2017
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-12-19) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-19) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-19) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-12-20) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-27) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-19) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-03-08) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-09-26) - AA
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-11-23) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-23) - PSC01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-23) - PSC02
-
legacy (2017-03-10) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-23) - PSC07
-
legacy (2017-12-18) - RP04CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-20) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-03-08) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-07) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-07) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-18) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-28) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-27) - MR01
-
resolution (2016-04-28) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2016-05-03) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-05-03) - SH08
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-05-04) - SH02
-
incorporation-company (2016-03-02) - NEWINC