-
WHITE CAR LIMITED - Olympia House, Armitage Road, London, NW11 8RQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10013367
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Olympia House
- Armitage Road
- London
- NW11 8RQ Olympia House, Armitage Road, London, NW11 8RQ UK
Management
- Geschäftsführung
- BALEN, Robin
- KAINTZ, Scott Christopher
- LAWFORD-POTTER, Christina
- LEWIS, Ian Anthony
- STRACHAN, Mark Douglas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.02.2016
- Alter der Firma 2016-02-18 8 Jahre
- SIC/NACE
- 77110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Mark Douglas Strachan
- Mrs Christina Lawford-Potter
- Mr Ian Anthony Lewis
- Mrs Christina Lawford-Potter
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-11-30
- Letzte Einreichung: 2018-02-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-03-02
- Letzte Einreichung: 2019-02-17
-
WHITE CAR LIMITED Firmenbeschreibung
- WHITE CAR LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10013367. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.02.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "77110" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 28.02.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Olympia House erreicht werden.
Jetzt sichern WHITE CAR LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: White Car Limited - Olympia House, Armitage Road, London, NW11 8RQ, Grossbritannien
- 2016-02-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WHITE CAR LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-05-10) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-06-17) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-06-10) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-06-10) - 600
-
resolution (2019-06-10) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-03-18) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-07) - CS01
-
capital-allotment-shares (2019-03-01) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-06-11) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-04-25) - SH08
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-28) - AA
-
capital-allotment-shares (2018-08-06) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2018-04-26) - SH02
-
capital-allotment-shares (2018-04-26) - SH01
-
resolution (2018-04-23) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-05) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-04-05) - PSC01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-15) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-09) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-22) - AP01
-
capital-allotment-shares (2017-04-29) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2017-04-29) - SH02
-
resolution (2017-04-24) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-05) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-11) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
incorporation-company (2016-02-18) - NEWINC