-
ROCKAR 2016 LIMITED - 1 Monckton Court, South Newbald Road, North Newbald, YO43 4RW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09969640
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Monckton Court
- South Newbald Road
- North Newbald
- YO43 4RW
- England 1 Monckton Court, South Newbald Road, North Newbald, YO43 4RW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- COLLIS, Michael Christopher
- DIXON, Simon Timothy
- MANLEY, Richard Edward
- MCEWAN, Andrew David John
- PATTERN, Adrian Leonard
- OOSTHUIZEN, Jan
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.01.2016
- Alter der Firma 2016-01-26 8 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Simon Timothy Dixon
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-09-30
- Letzte Einreichung: 2023-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-02-08
- Letzte Einreichung: 2024-01-25
-
ROCKAR 2016 LIMITED Firmenbeschreibung
- ROCKAR 2016 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09969640. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.01.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 1 Monckton Court erreicht werden.
Jetzt sichern ROCKAR 2016 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Rockar 2016 Limited - 1 Monckton Court, South Newbald Road, North Newbald, YO43 4RW, Grossbritannien
- 2016-01-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ROCKAR 2016 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-full (2024-09-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-01-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-11-06) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-10-03) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-03-03) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-03-01) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-27) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-11-02) - TM01
keyboard_arrow_right 2022
-
resolution (2022-08-23) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-10-01) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-06-28) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-06-24) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-06-24) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-02-04) - CS01
-
memorandum-articles (2022-08-22) - MA
keyboard_arrow_right 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-27) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-06-28) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-10-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-03) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-11) - AP01
-
resolution (2020-11-24) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2020-11-24) - MA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-09-16) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-06-12) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-06) - CS01
-
capital-allotment-shares (2018-01-09) - SH01
-
resolution (2018-01-05) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-05-24) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-09-21) - AA
-
resolution (2017-09-20) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2017-06-14) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-22) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-19) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-03) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-12-08) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-11) - AP01
-
resolution (2016-07-25) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-07-25) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-07-18) - MR01
-
incorporation-company (2016-01-26) - NEWINC
-
resolution (2016-05-18) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2016-05-20) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-15) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-15) - AP01
-
capital-allotment-shares (2016-07-15) - SH01