-
SMALL BATCH COFFEE HOLDINGS LIMITED - Unit 7 Camden Street, Portslade, Brighton, BN41 1DU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09836789
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 7 Camden Street
- Portslade
- Brighton
- BN41 1DU
- England Unit 7 Camden Street, Portslade, Brighton, BN41 1DU, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ALLESCH-TAYLOR, Stefan
- Prokuristen
- LOPEZ, Ashley
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.10.2015
- Alter der Firma 2015-10-22 8 Jahre
- SIC/NACE
- 46370
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Luke Oliver Johnson
- Mr Gerges Raphael
- -
- -
- -
- Mr. Stefan Paul Allesch-Taylor
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-15
- Letzte Einreichung: 2021-06-01
-
SMALL BATCH COFFEE HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- SMALL BATCH COFFEE HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09836789. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.10.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46370" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 7 Camden Street erreicht werden.
Jetzt sichern SMALL BATCH COFFEE HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Small Batch Coffee Holdings Limited - Unit 7 Camden Street, Portslade, Brighton, BN41 1DU, Grossbritannien
- 2015-10-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SMALL BATCH COFFEE HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-09-07) - PSC01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2021-09-07) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-04-23) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-06) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-08-24) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-08-27) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-12) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-06-30) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-06-25) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-06-25) - PSC01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-06-25) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-12-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-11) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-03-12) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-12) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-03-12) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-12) - PSC07
-
resolution (2019-03-20) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-05) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-31) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-12-04) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2019-12-11) - AA01
-
resolution (2019-12-31) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2019-03-12) - SH01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-22) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-04) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-27) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-09-26) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-18) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-05) - AD01
-
resolution (2017-04-25) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-04-26) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-14) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-22) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2015-11-30) - SH10
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-30) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-12-16) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-30) - AD01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-11-30) - SH08
-
resolution (2015-11-30) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-19) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-22) - TM01
-
incorporation-company (2015-10-22) - NEWINC