-
SMART BUSINESS LINK LIMITED - 130 Asquith Avenue, Morley, Leeds, LS27 9QX, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09802472
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 130 Asquith Avenue
- Morley
- Leeds
- LS27 9QX
- England 130 Asquith Avenue, Morley, Leeds, LS27 9QX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BLAND, Simon Christopher
- PUGH, Steven Richard
- SMITH, Gary
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.09.2015
- Alter der Firma 2015-09-30 8 Jahre
- SIC/NACE
- 64992
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Richard Pugh
- Mr Gary Smith
- -
- -
- Mr Gary Smith
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- COMMERCIAL FACTORING SOLUTIONS LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-13
- Letzte Einreichung: 2023-09-29
-
SMART BUSINESS LINK LIMITED Firmenbeschreibung
- SMART BUSINESS LINK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09802472. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.09.2015 registriert. SMART BUSINESS LINK LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen COMMERCIAL FACTORING SOLUTIONS LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64992" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 130 Asquith Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern SMART BUSINESS LINK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Smart Business Link Limited - 130 Asquith Avenue, Morley, Leeds, LS27 9QX, Grossbritannien
- 2015-09-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SMART BUSINESS LINK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
resolution (2024-05-17) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2023
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-06-14) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-11-03) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-03-24) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-09) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-01-31) - MR01
-
capital-sale-or-transfer-treasury-shares-with-date-currency-capital-figure (2022-03-31) - SH04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-07-14) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-08-10) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-09-14) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-11-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-05) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-09-17) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-06-30) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-03) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-20) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-12-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-26) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares-treasury-capital-date (2020-02-26) - SH03
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-12-30) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-03-08) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2019-03-08) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-03-09) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-11) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-12-13) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-22) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-07-15) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-07-23) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-11) - CS01
-
resolution (2019-03-15) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-02) - AAMD
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-09-28) - AA
-
capital-allotment-shares (2018-03-12) - SH01
-
resolution (2018-03-12) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-06) - MR01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-12) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-27) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-10-17) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-06-30) - AA
-
resolution (2017-03-07) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2017-02-17) - SH01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-10-25) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-13) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-10-13) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-23) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-10-30) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-10-30) - AD01
-
incorporation-company (2015-09-30) - NEWINC