-
HEATHCROFT PROPERTY INVESTMENTS LIMITED - The Old Town Hall, 71 Christchurch Road, Ringwood, BH24 1DH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09790330
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Old Town Hall
- 71 Christchurch Road
- Ringwood
- BH24 1DH The Old Town Hall, 71 Christchurch Road, Ringwood, BH24 1DH UK
Management
- Geschäftsführung
- PATTERSON, Giles William Frederick
- WEBSTER, Stephen John
- PEARSON-GREGORY, Guy Thomas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.09.2015
- Alter der Firma 2015-09-23 8 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Heathcroft Finance Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800485HHD89VBAU08
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-06
- Letzte Einreichung: 2023-09-22
-
HEATHCROFT PROPERTY INVESTMENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- HEATHCROFT PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09790330. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.09.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über The Old Town Hall erreicht werden.
Jetzt sichern HEATHCROFT PROPERTY INVESTMENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Heathcroft Property Investments Limited - The Old Town Hall, 71 Christchurch Road, Ringwood, BH24 1DH, Grossbritannien
- 2015-09-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HEATHCROFT PROPERTY INVESTMENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2024-02-07) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2024-02-07) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2024-01-26) - MR04
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2024-02-07) - LIQ01
-
resolution (2024-02-07) - RESOLUTIONS
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2024-01-23) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2023
-
gazette-notice-compulsory (2023-11-28) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2023-09-26) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-07-05) - CH01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-10-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-29) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-07-28) - AP01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-07-22) - PSC05
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-09-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-01-15) - MR04
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-12-22) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-02-13) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-22) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-11-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-28) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-12-11) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-12-04) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-10) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-20) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-09-17) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-05) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-05) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-10-05) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-29) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-05-31) - CH01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-01-30) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-05-23) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-11) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-01) - AP01
-
resolution (2016-04-01) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-14) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-29) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-12-15) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-30) - MR01
-
capital-allotment-shares (2015-10-27) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-27) - AP01
-
incorporation-company (2015-09-23) - NEWINC
-
resolution (2015-12-15) - RESOLUTIONS