-
INTEGRITY REFURBISHMENT LIMITED - Alexander House Waters Edge Businerss Park, Campbell Road, Stoke On Trent, Staffordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09773179
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Alexander House Waters Edge Businerss Park
- Campbell Road
- Stoke On Trent
- Staffordshire
- ST4 4DB Alexander House Waters Edge Businerss Park, Campbell Road, Stoke On Trent, Staffordshire, ST4 4DB UK
Management
- Geschäftsführung
- CROSBIE, Gary Stuart
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.09.2015
- Alter der Firma 2015-09-11 8 Jahre
- SIC/NACE
- 43290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- M V S REFURBISHMENT LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-05-31
- Letzte Einreichung: 2017-02-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-09-26
- Letzte Einreichung: 2017-09-12
-
INTEGRITY REFURBISHMENT LIMITED Firmenbeschreibung
- INTEGRITY REFURBISHMENT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09773179. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.09.2015 registriert. INTEGRITY REFURBISHMENT LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen M V S REFURBISHMENT LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43290" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 28.02.2017 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Alexander House Waters Edge Businerss Park erreicht werden.
Jetzt sichern INTEGRITY REFURBISHMENT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Integrity Refurbishment Limited - Alexander House Waters Edge Businerss Park, Campbell Road, Stoke On Trent, Staffordshire, Grossbritannien
- 2015-09-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu INTEGRITY REFURBISHMENT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-01-13) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-01-15) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-01-24) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-disclaimer-notice (2018-02-21) - NDISC
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-02-16) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-12-14) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2017-12-05) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-12-05) - 600
-
resolution (2017-12-05) - RESOLUTIONS
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-08-18) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-12) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-12) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-12) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-12) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-18) - CS01
-
resolution (2017-09-13) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-18) - PSC02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-26) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-26) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-03-21) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-22) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-03-27) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-21) - AP01
-
resolution (2017-05-05) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-09) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2017-06-10) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-03-29) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-10-26) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-23) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-08-19) - MR01
-
capital-allotment-shares (2016-05-06) - SH01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-12-02) - AD01
-
incorporation-company (2015-09-11) - NEWINC