-
VERSE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED - 2 Friars Bridge Road, Ipswich, Suffolk, IP1 1RR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09720915
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2 Friars Bridge Road
- Ipswich
- Suffolk
- IP1 1RR
- United Kingdom 2 Friars Bridge Road, Ipswich, Suffolk, IP1 1RR, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BUET, Keith Paul
- KORWIN-WROBLEWSKI, Jillian Lina
- SMITH, Jamie Alexander
- STURMAN, Tanya-Jane
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.08.2015
- Alter der Firma 2015-08-06 8 Jahre
- SIC/NACE
- 81100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Vertas Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-08-19
- Letzte Einreichung: 2023-08-05
-
VERSE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED Firmenbeschreibung
- VERSE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09720915. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.08.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "81100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2 Friars Bridge Road erreicht werden.
Jetzt sichern VERSE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Verse Facilities Management Limited - 2 Friars Bridge Road, Ipswich, Suffolk, IP1 1RR, Grossbritannien
- 2015-08-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VERSE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-08-20) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-04-01) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-01-27) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2023-01-13) - AA
-
legacy (2023-01-13) - GUARANTEE2
-
legacy (2023-01-13) - AGREEMENT2
-
legacy (2023-01-13) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2023-12-13) - AA
-
legacy (2023-12-13) - PARENT_ACC
-
legacy (2023-12-13) - GUARANTEE2
-
legacy (2023-12-13) - AGREEMENT2
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-11) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-11-07) - TM01
keyboard_arrow_right 2021
-
legacy (2021-11-15) - PARENT_ACC
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-05) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-04-30) - AP01
-
legacy (2021-11-15) - AGREEMENT2
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-04-12) - TM01
-
legacy (2021-11-15) - GUARANTEE2
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-11-15) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
legacy (2020-12-15) - AGREEMENT2
-
legacy (2020-12-15) - GUARANTEE2
-
mortgage-charge-whole-release-with-charge-number (2020-09-16) - MR05
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-09-16) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-09-09) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-18) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-09) - TM01
-
legacy (2020-12-15) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-12-15) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-08) - TM01
-
legacy (2019-10-10) - GUARANTEE2
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-21) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-02-11) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-08) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-05) - CS01
-
legacy (2019-10-10) - AGREEMENT2
-
legacy (2019-10-10) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2019-10-10) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-30) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-14) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-28) - TM01
-
legacy (2018-12-31) - GUARANTEE2
-
legacy (2018-12-31) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2018-12-31) - AA
-
legacy (2018-12-31) - AGREEMENT2
keyboard_arrow_right 2017
-
legacy (2017-10-03) - AGREEMENT2
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2017-10-03) - AA
-
legacy (2017-10-03) - PARENT_ACC
-
legacy (2017-10-03) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-09) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-04) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-03) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-11-07) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-19) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-14) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-08-12) - AA01
-
incorporation-company (2015-08-06) - NEWINC