-
WILDEAGLE BRAND CO LTD - Unit 2 Springfield Court, Summerfield Road, Bolton, BL3 2NT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09689292
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 2 Springfield Court
- Summerfield Road
- Bolton
- BL3 2NT
- England Unit 2 Springfield Court, Summerfield Road, Bolton, BL3 2NT, England UK
Management
- Geschäftsführung
- FOSTER, Phil
- SCOTT, Clair Marie
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.07.2015
- Alter der Firma 2015-07-16 8 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Seahawk Bidco Limited
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- LOVE SAVING GROUP LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-29
- Letzte Einreichung: 2023-03-15
-
WILDEAGLE BRAND CO LTD Firmenbeschreibung
- WILDEAGLE BRAND CO LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09689292. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.07.2015 registriert. WILDEAGLE BRAND CO LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen LOVE SAVING GROUP LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 2 Springfield Court erreicht werden.
Jetzt sichern WILDEAGLE BRAND CO LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Wildeagle Brand Co Ltd - Unit 2 Springfield Court, Summerfield Road, Bolton, BL3 2NT, Grossbritannien
- 2015-07-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WILDEAGLE BRAND CO LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-03) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-06-22) - AP01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-18) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-01-19) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-12-19) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
certificate-change-of-name-company (2021-11-09) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-29) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-21) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-29) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-09-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-08-21) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-08-24) - MR01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-10-25) - PSC07
-
capital-alter-shares-consolidation (2018-09-10) - SH02
-
resolution (2018-09-10) - RESOLUTIONS
-
second-filing-capital-allotment-shares (2018-09-10) - RP04SH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-08) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-08) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-08) - PSC02
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-09-07) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2018-09-07) - SH10
-
capital-allotment-shares (2018-08-31) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-10-01) - PSC02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-08-24) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-07-19) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-06-09) - AA
-
resolution (2017-05-25) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-26) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-25) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-30) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-30) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-25) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-05-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-25) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-14) - MR01
-
resolution (2015-10-02) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-10-02) - SH08
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-10-02) - SH02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-02) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-10-02) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-02) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-03) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-10-06) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-11-03) - AA01
-
certificate-change-of-name-company (2015-11-03) - CERTNM
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-10-02) - AD01
-
incorporation-company (2015-07-16) - NEWINC