-
BLUE RIVER INTERNATIONAL LTD - The Fresh Produce Centre, Transfesa Road, Paddock Wood, Kent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09660189
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Fresh Produce Centre
- Transfesa Road
- Paddock Wood
- Kent
- TN12 6UT
- United Kingdom The Fresh Produce Centre, Transfesa Road, Paddock Wood, Kent, TN12 6UT, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- FLETCHER, Martyn Paul
- MACK, Christopher Peter
- REES, Charles Hugh
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.06.2015
- Gelöscht am:
- 2022-07-19
- SIC/NACE
- 46310
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Stuart Colin Buchanan
- Amanda Mary Jane Buchanan
- Fresca Group Limited
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-01-31
- Letzte Einreichung: 2020-04-24
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-11-08
- Letzte Einreichung: 2021-10-25
-
BLUE RIVER INTERNATIONAL LTD Firmenbeschreibung
- BLUE RIVER INTERNATIONAL LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09660189. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 26.06.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46310" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 24.04.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über The Fresh Produce Centre erreicht werden.
Jetzt sichern BLUE RIVER INTERNATIONAL LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Blue River International Ltd - The Fresh Produce Centre, Transfesa Road, Paddock Wood, Kent, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BLUE RIVER INTERNATIONAL LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
resolution (2021-11-12) - RESOLUTIONS
-
legacy (2021-11-12) - CAP-SS
-
legacy (2021-11-12) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2021-11-12) - SH19
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-06-28) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-10-18) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-26) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-02-01) - TM01
-
legacy (2021-04-12) - GUARANTEE2
-
legacy (2021-04-12) - AGREEMENT2
-
resolution (2021-04-12) - RESOLUTIONS
-
legacy (2021-05-06) - PARENT_ACC
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-01-06) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-03) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-27) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-09-07) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-07) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-01-07) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-07) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-07) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2019-01-07) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-01-07) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-03-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-27) - CS01
-
legacy (2019-08-07) - GUARANTEE2
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-08-15) - TM02
-
legacy (2019-10-24) - GUARANTEE2
-
legacy (2019-10-24) - AGREEMENT2
-
legacy (2019-10-24) - PARENT_ACC
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-01) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-01-21) - CH01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-01-07) - TM02
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2018-07-06) - CH03
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-19) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-12-21) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-28) - MR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-07-06) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-07-06) - PSC04
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-03-26) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-06) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-19) - PSC02
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-07-06) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-09-20) - DISS40
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-19) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-19) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2017-09-12) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-24) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-12) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-07) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-06-26) - NEWINC