-
NIMBUS ACQUISITIONS BIDCO LIMITED - Forum St Paul's 33 Gutter Lane, Second Floor, London, EC2V 8AS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09651062
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Forum St Paul's 33 Gutter Lane
- Second Floor
- London
- EC2V 8AS
- United Kingdom Forum St Paul's 33 Gutter Lane, Second Floor, London, EC2V 8AS, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- ANDERSON, Clinton
- WHITMARSH, John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.06.2015
- Alter der Firma 2015-06-22 8 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Nimbus Acquisitions Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- NIMBUS ACQUISITIONS TOPCO LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 5493006QKKXDRT5GN257
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-07-19
- Letzte Einreichung: 2022-07-05
-
NIMBUS ACQUISITIONS BIDCO LIMITED Firmenbeschreibung
- NIMBUS ACQUISITIONS BIDCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09651062. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.06.2015 registriert. NIMBUS ACQUISITIONS BIDCO LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen NIMBUS ACQUISITIONS TOPCO LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Forum St Paul's 33 Gutter Lane erreicht werden.
Jetzt sichern NIMBUS ACQUISITIONS BIDCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Nimbus Acquisitions Bidco Limited - Forum St Paul's 33 Gutter Lane, Second Floor, London, EC2V 8AS, Grossbritannien
- 2015-06-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NIMBUS ACQUISITIONS BIDCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-07-15) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2022-09-20) - SH19
-
legacy (2022-09-20) - SH20
-
legacy (2022-09-20) - CAP-SS
-
resolution (2022-09-20) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2022-09-16) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-10-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-07-22) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-07-22) - CH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-07-18) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-07-18) - PSC07
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-09-04) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-06) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-06-09) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-02-19) - AP01
-
second-filing-capital-allotment-shares (2020-09-29) - RP04SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-19) - TM01
-
resolution (2020-03-10) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2020-08-27) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-03-12) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-07-09) - MR04
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2019-12-20) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-27) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-16) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-16) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-15) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-05-17) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-06-06) - AA
-
capital-allotment-shares (2018-10-15) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-09-12) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-05-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-05) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-10-11) - PSC02
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-06-28) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-06-09) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-31) - MR01
-
capital-allotment-shares (2015-08-27) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-08-27) - AA01
-
certificate-change-of-name-company (2015-08-16) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-11) - TM01
-
resolution (2015-08-06) - RESOLUTIONS
-
resolution (2015-08-03) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2015-06-22) - NEWINC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-08-11) - AD01