-
ENERGY CIRCLE PLC - C/O ABSOLUTE RECOVERY, Unit 2 Railway Court Ten Pound Walk, Doncaster, DN4 5FB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09634725
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O ABSOLUTE RECOVERY
- Unit 2 Railway Court Ten Pound Walk
- Doncaster
- DN4 5FB C/O ABSOLUTE RECOVERY, Unit 2 Railway Court Ten Pound Walk, Doncaster, DN4 5FB UK
Management
- Geschäftsführung
- NICOLL, Graham Roy
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- plc
- Gründungsdatum
- 11.06.2015
- Alter der Firma 2015-06-11 8 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Stephen Khan
- Mr Stephen Khan
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- EC RENEWABLES PLC
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800X2DGVGFF1CAP84
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-09-30
- Letzte Einreichung: 2018-12-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-10-03
- Letzte Einreichung: 2019-08-22
-
ENERGY CIRCLE PLC Firmenbeschreibung
- ENERGY CIRCLE PLC ist eine in Grossbritannien als plc registrierte Firma mit der Register-Nr. 09634725. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.06.2015 registriert. ENERGY CIRCLE PLC hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen EC RENEWABLES PLC ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 29.12.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Absolute Recovery erreicht werden.
Jetzt sichern ENERGY CIRCLE PLC HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Energy Circle Plc - C/O ABSOLUTE RECOVERY, Unit 2 Railway Court Ten Pound Walk, Doncaster, DN4 5FB, Grossbritannien
- 2015-06-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ENERGY CIRCLE PLC aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-05-26) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-13) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-01-13) - TM02
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-06-11) - LIQ02
-
resolution (2020-05-26) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-05-28) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-05-18) - 600
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-24) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-07-09) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-07) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-06-29) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-08) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-10-16) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-cancellation-shares (2017-02-08) - SH06
-
resolution (2017-11-22) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-12) - TM01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2017-10-09) - CH03
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-22) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-08-22) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-04-27) - AD01
-
capital-allotment-shares (2017-01-24) - SH01
-
resolution (2017-01-24) - RESOLUTIONS
-
capital-return-purchase-own-shares (2017-01-24) - SH03
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-05-10) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-15) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-03) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-03) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-08) - CS01
-
certificate-change-of-name-company (2016-08-08) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-26) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-08-26) - TM02
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-08-26) - CH01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-08-26) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-20) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-14) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-12-22) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
legacy (2015-06-18) - CERT8A
-
application-trading-certificate (2015-06-18) - SH50
-
incorporation-company (2015-06-11) - NEWINC