-
WINDERS ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED - 128 Station Road, Glenfield, Leicester, LE3 8BR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09631578
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 128 Station Road
- Glenfield
- Leicester
- LE3 8BR
- England 128 Station Road, Glenfield, Leicester, LE3 8BR, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CLARRIDGE, Kimberley Ann
- WINDER, Craig Alan
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.06.2015
- Alter der Firma 2015-06-10 9 Jahre
- SIC/NACE
- 43210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Winders Holdings Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-26
- Letzte Einreichung: 2020-12-12
-
WINDERS ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED Firmenbeschreibung
- WINDERS ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09631578. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.06.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43210" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 128 Station Road erreicht werden.
Jetzt sichern WINDERS ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Winders Electrical Contractors Limited - 128 Station Road, Glenfield, Leicester, LE3 8BR, Grossbritannien
- 2015-06-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WINDERS ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-20) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-08-03) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-14) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-11-19) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-12) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-05) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-12-05) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-02) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-08-30) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-08) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-02-16) - AP03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-12-27) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-12) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-12) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-12-12) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-12) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-12-12) - TM02
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-09-02) - SH08
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-06-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-13) - CS01
-
resolution (2017-09-05) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-16) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-01-14) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-10-05) - RESOLUTIONS
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2015-10-05) - SH10
-
capital-allotment-shares (2015-10-05) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-05) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-10-06) - AP03
-
resolution (2015-11-17) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-09) - AP01
-
resolution (2015-12-01) - RESOLUTIONS
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2015-12-01) - SH10
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-01) - AP01
-
incorporation-company (2015-06-10) - NEWINC