-
MFG LEGAL SERVICES LIMITED - Adam House, Birmingham Road, Kidderminster, Worcestershire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09623537
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Adam House
- Birmingham Road
- Kidderminster
- Worcestershire
- DY10 2SH
- United Kingdom Adam House, Birmingham Road, Kidderminster, Worcestershire, DY10 2SH, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- LEE, Suzanne Jane
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.06.2015
- Alter der Firma 2015-06-04 8 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mfg Solicitors Llp
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-01-31
- Letzte Einreichung: 2021-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-18
- Letzte Einreichung: 2021-06-04
-
MFG LEGAL SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- MFG LEGAL SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09623537. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.06.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Adam House erreicht werden.
Jetzt sichern MFG LEGAL SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mfg Legal Services Limited - Adam House, Birmingham Road, Kidderminster, Worcestershire, Grossbritannien
- 2015-06-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MFG LEGAL SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-09-07) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-09) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-08-25) - PSC02
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2021-08-25) - PSC09
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-12) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-05) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-13) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-08-20) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-19) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-10) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-21) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-20) - AA
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-09-27) - SH02
-
resolution (2016-09-09) - RESOLUTIONS
-
second-filing-capital-allotment-shares (2016-08-02) - RP04SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-21) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-21) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-07-21) - CH01
-
capital-allotment-shares (2016-06-22) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-01-04) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-29) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-06-29) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-29) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-06-29) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-30) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-07-21) - SH01
-
incorporation-company (2015-06-04) - NEWINC