-
MILLER WATES (DIDCOT) LIMITED - 2, Centro Place, Pride Park, Derby, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09606711
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2
- Centro Place
- Pride Park
- Derby
- Derbyshire
- DE24 8RF 2, Centro Place, Pride Park, Derby, Derbyshire, DE24 8RF UK
Management
- Geschäftsführung
- BOWEN, David Alexander
- BRAYSHAW, Michael Howard
- BROCKLEBANK, David Michael
- FLINT, Natalie Jane
- FORBES-TAYLOR, Tracey Lorraine
- JACKSON, Julie Mansfield
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.05.2015
- Alter der Firma 2015-05-23 8 Jahre
- SIC/NACE
- 41202
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Miller Homes Holdings Limited
- Wates Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- MILLER HOMES (DIDCOT) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-14
- Letzte Einreichung: 2020-05-31
-
MILLER WATES (DIDCOT) LIMITED Firmenbeschreibung
- MILLER WATES (DIDCOT) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09606711. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.05.2015 registriert. MILLER WATES (DIDCOT) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MILLER HOMES (DIDCOT) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41202" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2 erreicht werden.
Jetzt sichern MILLER WATES (DIDCOT) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Miller Wates (Didcot) Limited - 2, Centro Place, Pride Park, Derby, Grossbritannien
- 2015-05-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MILLER WATES (DIDCOT) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-31) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-03) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-17) - TM01
-
termination-director-company (2020-08-26) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-10-01) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-07) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-09-09) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-18) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-18) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-02-26) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-06-28) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-06-21) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-06) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-07-25) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-10-02) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-12-22) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-08-05) - MR04
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-27) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-08-22) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-12-05) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-27) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-13) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-14) - AR01
-
resolution (2016-05-05) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-26) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-22) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-09-25) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-09-28) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-09-28) - TM02
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-09-28) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-29) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-07) - AP01
-
change-of-name-notice (2015-10-14) - CONNOT
-
resolution (2015-11-10) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2015-05-23) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2015-11-10) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-11-10) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2015-11-10) - SH10
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-19) - AP01
-
mortgage-acquire-with-deed-with-charge-number-charge-acquisition-date (2015-12-09) - MR02
-
certificate-change-of-name-company (2015-10-14) - CERTNM
-
certificate-change-of-name-company (2015-09-08) - CERTNM