-
SWAT GROUP LIMITED - 5th Floor 10 Whitechapel High Street, London, E1 8QS, United Kingdom, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09572812
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5th Floor 10 Whitechapel High Street
- London
- E1 8QS
- United Kingdom 5th Floor 10 Whitechapel High Street, London, E1 8QS, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- MILLWARD, Guy Leighton
- MILNER, Mark Francis
- Prokuristen
- TAHIR, Saira Jamil Hussain
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.05.2015
- Gelöscht am:
- 2023-08-20
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mercia Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-05-19
- Letzte Einreichung: 2020-05-05
-
SWAT GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- SWAT GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09572812. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 05.05.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 5Th Floor 10 Whitechapel High Street erreicht werden.
Jetzt sichern SWAT GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Swat Group Limited - 5th Floor 10 Whitechapel High Street, London, E1 8QS, United Kingdom, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SWAT GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2023-05-20) - LIQ13
-
gazette-dissolved-liquidation (2023-08-20) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-11-16) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-05) - CS01
-
legacy (2021-04-22) - GUARANTEE2
-
legacy (2021-04-22) - AGREEMENT2
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-01-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-01-07) - AP01
-
legacy (2021-04-22) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-04-22) - AA
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-09-29) - 600
-
resolution (2021-10-01) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2021-10-01) - LIQ01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2020-03-09) - AA
-
legacy (2020-03-09) - PARENT_ACC
-
legacy (2020-03-09) - AGREEMENT2
-
legacy (2020-03-09) - GUARANTEE2
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-05-29) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-03-15) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-23) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-23) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-14) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-17) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-29) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-08-29) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-05-28) - AP03
keyboard_arrow_right 2018
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-01-19) - PSC05
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-12) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-08) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-12) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-04-04) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-12-15) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-26) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-07-26) - MR04
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-03-16) - CH03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-31) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-18) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-07-22) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-07-22) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-08-16) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-07-26) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-26) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-07-26) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-07-26) - TM02
-
resolution (2016-08-01) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-08-10) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-08-10) - AP03
-
incorporation-company (2015-05-05) - NEWINC
-
resolution (2015-07-24) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-08-24) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-21) - MR01