-
SBH GATWICK LIMITED - C/O STARBOARD HOTELS LTD, Park House, 10 Penn Road, Beaconsfield, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09556199
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O STARBOARD HOTELS LTD
- Park House
- 10 Penn Road
- Beaconsfield
- Buckinghamshire
- HP9 2LH
- England C/O STARBOARD HOTELS LTD, Park House, 10 Penn Road, Beaconsfield, Buckinghamshire, HP9 2LH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CALLINGHAM, Paul Arthur
- SCHREIBER, Jacob
- SCHREIBER, Miriam
- SCHREIBER, Moses
- CALLINGHAM, Frazer George
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.04.2015
- Alter der Firma 2015-04-23 9 Jahre
- SIC/NACE
- 55100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Paul Arthur Callingham
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800VMYQUETY3U3U32
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-03-28
- Letzte Einreichung: 2023-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-02
- Letzte Einreichung: 2023-06-18
-
SBH GATWICK LIMITED Firmenbeschreibung
- SBH GATWICK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09556199. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.04.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "55100" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über C/o Starboard Hotels Ltd erreicht werden.
Jetzt sichern SBH GATWICK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sbh Gatwick Limited - C/O STARBOARD HOTELS LTD, Park House, 10 Penn Road, Beaconsfield, Grossbritannien
- 2015-04-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SBH GATWICK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-03-07) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-03-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-02-11) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-06-23) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-24) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-29) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-07) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-03-28) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-04) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-29) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-02-23) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-10-05) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-28) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-06) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-12-22) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-30) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-04) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-12) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-07-21) - AD01
-
memorandum-articles (2015-07-16) - MA
-
resolution (2015-07-16) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-02) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-01) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-18) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-14) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-13) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-12) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2015-05-12) - AP01
-
incorporation-company (2015-04-23) - NEWINC