-
NATIONAL GAS AND POWER LIMITED - Bulman House, Regent Centre, Gosforth, Newcastle Upon Tyne, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09523569
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Bulman House
- Regent Centre
- Gosforth
- Newcastle Upon Tyne
- NE3 3LS Bulman House, Regent Centre, Gosforth, Newcastle Upon Tyne, NE3 3LS UK
Management
- Geschäftsführung
- SHAHZAD, Mamuna
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.04.2015
- Gelöscht am:
- 2021-12-04
- SIC/NACE
- 47910
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Mamuna Shahzad
- Mrs Mamuna Shahzad
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-01-29
- Letzte Einreichung: 2017-04-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-02-02
- Letzte Einreichung: 2018-01-19
-
NATIONAL GAS AND POWER LIMITED Firmenbeschreibung
- NATIONAL GAS AND POWER LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09523569. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 02.04.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47910" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Bulman House erreicht werden.
Jetzt sichern NATIONAL GAS AND POWER LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: National Gas And Power Limited - Bulman House, Regent Centre, Gosforth, Newcastle Upon Tyne, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NATIONAL GAS AND POWER LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-09-04) - LIQ14
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-04-08) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-07-15) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-04-17) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-03-04) - 600
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2019-02-13) - AM22
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2018-11-05) - AM07
-
liquidation-in-administration-proposals (2018-10-08) - AM03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-30) - AD01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2018-08-21) - AM01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-03-09) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-22) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-01-18) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-18) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-07) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-05-07) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-07) - AP01
-
incorporation-company (2015-04-02) - NEWINC