-
METIS FIRST LIMITED - Oak Tree House Harwood Road, Northminster Business Park, Upper Poppleton, York, YO26 6QU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09513586
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Oak Tree House Harwood Road
- Northminster Business Park, Upper Poppleton
- York
- YO26 6QU
- United Kingdom Oak Tree House Harwood Road, Northminster Business Park, Upper Poppleton, York, YO26 6QU, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.03.2015
- Alter der Firma 2015-03-27 9 Jahre
- SIC/NACE
- 64999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Paula Mcdermott
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-08-05
- Letzte Einreichung: 2019-07-22
-
METIS FIRST LIMITED Firmenbeschreibung
- METIS FIRST LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09513586. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.03.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64999" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Oak Tree House Harwood Road erreicht werden.
Jetzt sichern METIS FIRST LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Metis First Limited - Oak Tree House Harwood Road, Northminster Business Park, Upper Poppleton, York, YO26 6QU, Grossbritannien
- 2015-03-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu METIS FIRST LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-06-19) - MR04
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-08-13) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-07-08) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-05-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-23) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-19) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-08-13) - PSC01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-16) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-20) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-18) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-11) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-11) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-04-11) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-11) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-04) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-20) - AA
-
resolution (2017-11-29) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-28) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-28) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-11-22) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-22) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-15) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-05-15) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-05-15) - SH08
-
resolution (2015-05-15) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2015-03-27) - NEWINC