-
CANAVERAL BIDCO LIMITED - Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square, Spinningfields, Manchester, M3 3EB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09511818
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square
- Spinningfields
- Manchester
- M3 3EB Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square, Spinningfields, Manchester, M3 3EB UK
Management
- Geschäftsführung
- GOULDING, Merrill Graham
- JACKSON, Ian Barrie
- SCHMITZ, Christian
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.03.2015
- Alter der Firma 2015-03-26 9 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Merrill Goulding
- Canaveral Holdco Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-09-01
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-02-14
- Letzte Einreichung: 2020-01-03
-
CANAVERAL BIDCO LIMITED Firmenbeschreibung
- CANAVERAL BIDCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09511818. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.03.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square erreicht werden.
Jetzt sichern CANAVERAL BIDCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Canaveral Bidco Limited - Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square, Spinningfields, Manchester, M3 3EB, Grossbritannien
- 2015-03-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CANAVERAL BIDCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
resolution (2021-03-26) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2021-03-27) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-02-18) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-16) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-12-04) - DISS40
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-06-01) - AA01
-
gazette-notice-compulsory (2020-12-01) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-09-30) - AA01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-08-20) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-08-20) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-amended-with-accounts-type-full (2018-10-01) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-09-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-27) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-10-16) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-08) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-10) - PSC01
-
gazette-notice-compulsory (2017-06-13) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-06-27) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-06-24) - DISS40
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-31) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-27) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-27) - TM01
-
resolution (2016-04-05) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-23) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-06-16) - SH01
-
incorporation-company (2015-03-26) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-03-27) - AA01