-
IPRO SPORT DISTRIBUTION LTD - Suite E2, 2nd Floor The Octagon, Middleborough, Colchester, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09501344
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite E2, 2nd Floor The Octagon
- Middleborough
- Colchester
- Essex
- CO1 1TG
- United Kingdom Suite E2, 2nd Floor The Octagon, Middleborough, Colchester, Essex, CO1 1TG, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- CHRISTY, Sophie Louise
- GANDHUM, Jaswinder Singh
- GARRAD, Thomas Edward
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.03.2015
- Alter der Firma 2015-03-20 9 Jahre
- SIC/NACE
- 46341
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Thomas Edward Garrad
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- voluntary-arrangement
- Ehemalige Namen
- IPROSPORT DISTRIBUTION LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-06-30
- Letzte Einreichung: 2021-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-10-18
- Letzte Einreichung: 2022-10-04
-
IPRO SPORT DISTRIBUTION LTD Firmenbeschreibung
- IPRO SPORT DISTRIBUTION LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09501344. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.03.2015 registriert. IPRO SPORT DISTRIBUTION LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen IPROSPORT DISTRIBUTION LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46341" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Suite E2, 2Nd Floor The Octagon erreicht werden.
Jetzt sichern IPRO SPORT DISTRIBUTION LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ipro Sport Distribution Ltd - Suite E2, 2nd Floor The Octagon, Middleborough, Colchester, Essex, Grossbritannien
- 2015-03-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu IPRO SPORT DISTRIBUTION LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-01-26) - CS01
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2023-07-22) - CVA3
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2022-07-19) - CVA3
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-01-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-13) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-26) - CS01
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2021-07-23) - CVA3
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-28) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2020-07-15) - CVA3
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-11) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-05) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-13) - AA
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2019-06-06) - CVA1
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-02) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-21) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-16) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-11-16) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-03) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-03-28) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-03-27) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2018-03-06) - GAZ1
-
change-sail-address-company-with-new-address (2018-01-23) - AD02
keyboard_arrow_right 2017
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-06-24) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-22) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-02) - AP01
-
gazette-notice-compulsory (2017-06-13) - GAZ1
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-29) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-29) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-15) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-07) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-18) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-18) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-25) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-02-24) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-02-23) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-03-20) - NEWINC
-
certificate-change-of-name-company (2015-05-01) - CERTNM
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-05) - MR01