• UK
  • OFFICE GLASS SOLUTIONS LIMITED - Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road, Whitefield, Greater Manchester, M45 7TA, Grossbritannien

Firmenprofil

Handelsregisternummer
09498500
Firmenstatus
GELÖSCHT
Land
Grossbritannien
Protokollierter Sitz
Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road
Whitefield
Greater Manchester
M45 7TA
Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road, Whitefield, Greater Manchester, M45 7TA UK

Management

Geschäftsführung
OCALLAGHAN, John

Firmendetails

Geschäftszweig
ltd
Gründungsdatum
19.03.2015
Gelöscht am:
2024-01-27
SIC/NACE
43290

Eigentumsverhältnisse

Beneficial Owners
-
-
-
Mr Thomas O'Callaghan

Landes-Besonderheiten

Zusätzliche Statusdetails
Dissolved
Bilanzhinterlegung
Fälligkeit:
Letzte Einreichung: 2017-08-31

OFFICE GLASS SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung

OFFICE GLASS SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09498500. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 19.03.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43290" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road erreicht werden.
Mehr Information

Jetzt sichern OFFICE GLASS SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check

Sie befinden sich hier: Office Glass Solutions Limited - Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road, Whitefield, Greater Manchester, M45 7TA, Grossbritannien

Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu OFFICE GLASS SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.

In den Warenkorb
 

Handelsregisterauszug

Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens

In den Warenkorb
 

Jahresabschluss

Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr

In den Warenkorb
 

Liste der Gesellschafter

Angaben zu den Eigentumsverhältnissen

In den Warenkorb
 

Gesellschaftsvertrag

Gründungsdokumente

In den Warenkorb
 

Beneficial Owners Check

Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)

Amtliche Dokumente

Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister

  • gazette-dissolved-liquidation (2024-01-27) - GAZ2

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-10-27) - LIQ14

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-11-15) - LIQ03

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-10-08) - LIQ03

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-10-19) - LIQ03

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-11-13) - LIQ03

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2019-07-11) - LIQ10

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-07-11) - 600

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-satisfy-charge-full (2019-06-19) - MR04

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-10-08) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-10-04) - 600

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2018-10-04) - LIQ02

    In den Warenkorb
     
  • resolution (2018-10-04) - RESOLUTIONS

    In den Warenkorb
     
  • cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-06) - PSC07

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-06) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-satisfy-charge-full (2017-09-29) - MR04

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-09-06) - MR01

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-27) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-updates (2017-05-10) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-15) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-21) - AA

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-16) - AA

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-20) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-08-22) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • change-account-reference-date-company-current-extended (2016-05-19) - AA01

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-19) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-04) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-24) - MR01

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-23) - MR01

    In den Warenkorb
     
  • incorporation-company (2015-03-19) - NEWINC

    In den Warenkorb
     

expand_less