-
LUNAPOINT INVESTMENTS LIMITED - 3 Premier Park, Winsford, Cheshire, CW7 3PH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09484700
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3 Premier Park
- Winsford
- Cheshire
- CW7 3PH
- United Kingdom 3 Premier Park, Winsford, Cheshire, CW7 3PH, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- FISHER, Alison Marie
- FISHER, Nicholas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.03.2015
- Alter der Firma 2015-03-12 9 Jahre
- SIC/NACE
- 96090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Nicholas Fisher
- -
- -
- Mr Nicholas Fisher
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- VENTURE STUDIOS FRANCHISE LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-19
- Letzte Einreichung: 2021-05-05
-
LUNAPOINT INVESTMENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- LUNAPOINT INVESTMENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09484700. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.03.2015 registriert. LUNAPOINT INVESTMENTS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen VENTURE STUDIOS FRANCHISE LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96090" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 3 Premier Park erreicht werden.
Jetzt sichern LUNAPOINT INVESTMENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Lunapoint Investments Limited - 3 Premier Park, Winsford, Cheshire, CW7 3PH, Grossbritannien
- 2015-03-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LUNAPOINT INVESTMENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-14) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-10-08) - PSC09
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-07) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-20) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-05) - PSC01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-13) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-04-30) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-24) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-05-09) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-08-08) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-17) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-05-17) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-17) - AR01
-
capital-allotment-shares (2016-01-12) - SH01
-
resolution (2016-01-12) - RESOLUTIONS
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2016-01-12) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-01-12) - SH08
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-02-10) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-14) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-04-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-14) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-11) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-21) - AP01
-
change-of-name-notice (2015-06-24) - CONNOT
-
resolution (2015-06-02) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2015-06-24) - CERTNM
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-29) - MR01
-
change-of-name-notice (2015-06-02) - CONNOT
-
incorporation-company (2015-03-12) - NEWINC