-
VIRION BIOTHERAPEUTICS LIMITED - Cork Gully Llp, 6 Snow Hill, London, EC1A 2AY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09471528
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Cork Gully Llp
- 6 Snow Hill
- London
- EC1A 2AY Cork Gully Llp, 6 Snow Hill, London, EC1A 2AY UK
Management
- Geschäftsführung
- HAINES, Timothy John
- KING, Vanessa
- MOSES, Edwin, Dr
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.03.2015
- Alter der Firma 2015-03-04 9 Jahre
- SIC/NACE
- 72110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Abingworth Bioventures Vi Gp Lp
- Abingworth Bioventures Vii Gp Lp
- University Of Warwick
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Ehemalige Namen
- VIRIONHEALTH LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-02
- Letzte Einreichung: 2021-01-19
-
VIRION BIOTHERAPEUTICS LIMITED Firmenbeschreibung
- VIRION BIOTHERAPEUTICS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09471528. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.03.2015 registriert. VIRION BIOTHERAPEUTICS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen VIRIONHEALTH LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "72110" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Cork Gully Llp erreicht werden.
Jetzt sichern VIRION BIOTHERAPEUTICS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Virion Biotherapeutics Limited - Cork Gully Llp, 6 Snow Hill, London, EC1A 2AY, Grossbritannien
- 2015-03-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VIRION BIOTHERAPEUTICS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-08-22) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-08-11) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-07-07) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-06-26) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-06-22) - 600
-
resolution (2021-06-22) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2021-06-22) - LIQ01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-18) - CS01
-
resolution (2021-07-28) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-01-02) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-31) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-01) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-23) - TM01
-
capital-allotment-shares (2019-09-23) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-10-01) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-06) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-24) - AD01
-
resolution (2018-09-12) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2018-09-12) - CONNOT
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-17) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-10) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2018-05-22) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-02-02) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-28) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-01) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-06-12) - AA
-
capital-allotment-shares (2017-06-14) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-06-14) - CH01
-
resolution (2017-06-21) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2017-09-05) - SH01
-
second-filing-capital-allotment-shares (2017-09-25) - RP04SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-01) - TM01
-
capital-return-purchase-own-shares (2017-10-16) - SH03
-
resolution (2017-10-16) - RESOLUTIONS
-
resolution (2017-09-29) - RESOLUTIONS
-
capital-cancellation-shares (2017-10-16) - SH06
-
capital-allotment-shares (2017-10-16) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-10-30) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-10-30) - PSC07
-
capital-alter-shares-subdivision (2017-10-16) - SH02
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2016-10-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
certificate-change-of-name-company (2015-03-28) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2015-03-28) - CONNOT
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-11) - AD01
-
incorporation-company (2015-03-04) - NEWINC