-
EWC1 CAMPFIELD LIMITED - 3rd Floor South Building, 200 Aldersgate Street, London, EC1A 4HD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09461774
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3rd Floor South Building
- 200 Aldersgate Street
- London
- EC1A 4HD
- England 3rd Floor South Building, 200 Aldersgate Street, London, EC1A 4HD, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BURGESS, Benjamin Michael
- CUNNINGHAM, Thomas Samuel
- DYER, Jeremy Grahame
- WALKER, Adam Davey
- Prokuristen
- YORK, Kezia Samantha
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.02.2015
- Alter der Firma 2015-02-27 9 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Cape Re Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- MG SPV NO. 3 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-13
- Letzte Einreichung: 2021-02-27
-
EWC1 CAMPFIELD LIMITED Firmenbeschreibung
- EWC1 CAMPFIELD LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09461774. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.02.2015 registriert. EWC1 CAMPFIELD LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MG SPV NO. 3 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 3Rd Floor South Building erreicht werden.
Jetzt sichern EWC1 CAMPFIELD LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ewc1 Campfield Limited - 3rd Floor South Building, 200 Aldersgate Street, London, EC1A 4HD, Grossbritannien
- 2015-02-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EWC1 CAMPFIELD LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-12-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-01) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-06-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-06-07) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-12-21) - PSC05
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-08-13) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-07-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-20) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-08) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-08) - AP01
-
resolution (2019-02-08) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-09-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-12) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-10-31) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-09-20) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-09-11) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-23) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-05-03) - AA
-
resolution (2018-04-25) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-23) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-04-23) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-13) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-17) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-01-02) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-29) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-01-03) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-11) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-11) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-12) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-27) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-09-28) - AA01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-11-28) - PSC05
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-06-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-20) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-02-25) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-11) - MR01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-03-11) - AA01
-
incorporation-company (2015-02-27) - NEWINC