• UK
  • BOROUGH EDUCATIONAL FOUNDATION - Frp Advisory Llp Jupiter House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, Grossbritannien

Firmenprofil

Handelsregisternummer
09454099
Firmenstatus
GELÖSCHT
Land
Grossbritannien
Protokollierter Sitz
Frp Advisory Llp Jupiter House Warley Hill Business Park
The Drive
Brentwood
Essex
CM13 3BE
Frp Advisory Llp Jupiter House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, CM13 3BE UK

Management

Geschäftsführung
LIEBERMAN, Naftoli Meir
PRUIM, David
RUSSELL, Yitzhok Elhonon
Prokuristen
-

Firmendetails

Geschäftszweig
private-limited-guarant-nsc-limited-exemption
Gründungsdatum
23.02.2015
Gelöscht am:
2022-01-05
SIC/NACE
85590

Eigentumsverhältnisse

Beneficial Owners
-
Mr Michael Katz
Mr Salomon Zvi
-
-
-

Landes-Besonderheiten

Zusätzliche Statusdetails
dissolved
Bilanzhinterlegung
Fälligkeit: 2019-11-27
Letzte Einreichung: 2018-02-28
Jahresmeldung
Fälligkeit: 2020-03-08
Letzte Einreichung: 2019-02-23

BOROUGH EDUCATIONAL FOUNDATION Firmenbeschreibung

BOROUGH EDUCATIONAL FOUNDATION ist eine in Grossbritannien als private-limited-guarant-nsc-limited-exemption registrierte Firma mit der Register-Nr. 09454099. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.02.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "85590" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Frp Advisory Llp Jupiter House Warley Hill Business Park erreicht werden.
Mehr Information

Jetzt sichern BOROUGH EDUCATIONAL FOUNDATION HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check

Sie befinden sich hier: Borough Educational Foundation - Frp Advisory Llp Jupiter House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, Grossbritannien

Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BOROUGH EDUCATIONAL FOUNDATION aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.

In den Warenkorb
 

Handelsregisterauszug

Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens

In den Warenkorb
 

Jahresabschluss

Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr

In den Warenkorb
 

Liste der Gesellschafter

Angaben zu den Eigentumsverhältnissen

In den Warenkorb
 

Gesellschaftsvertrag

Gründungsdokumente

In den Warenkorb
 

Beneficial Owners Check

Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)

Amtliche Dokumente

Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister

  • liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2020-09-18) - WU07

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-19) - AA

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-25) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-25) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-29) - PSC07

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-satisfy-charge-full (2019-05-08) - MR04

    In den Warenkorb
     
  • gazette-notice-compulsory (2019-05-14) - GAZ1

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-05-23) - LIQ02

    In den Warenkorb
     
  • resolution (2019-05-23) - RESOLUTIONS

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-05-23) - 600

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-24) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-03) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-compulsory-winding-up-order (2019-07-10) - COCOMP

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-24) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2019-09-24) - WU04

    In den Warenkorb
     
  • change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-11-30) - AA01

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-13) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-19) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-15) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-03-06) - TM02

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-02-22) - MR01

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-13) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • confirmation-statement-with-updates (2017-03-17) - CS01

    In den Warenkorb
     
  • change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-16) - AD01

    In den Warenkorb
     
  • cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-22) - PSC07

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-22) - AA

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-11-22) - AP03

    In den Warenkorb
     
  • appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-23) - AP01

    In den Warenkorb
     
  • termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-22) - TM01

    In den Warenkorb
     
  • accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-12) - AA

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-09-03) - MR01

    In den Warenkorb
     
  • annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2016-04-07) - AR01

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-create-with-deed (2015-09-29) - MR01

    In den Warenkorb
     
  • mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-25) - MR01

    In den Warenkorb
     
  • incorporation-company (2015-02-23) - NEWINC

    In den Warenkorb
     

expand_less