-
BOROUGH EDUCATIONAL FOUNDATION - Frp Advisory Llp Jupiter House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09454099
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Frp Advisory Llp Jupiter House Warley Hill Business Park
- The Drive
- Brentwood
- Essex
- CM13 3BE Frp Advisory Llp Jupiter House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, CM13 3BE UK
Management
- Geschäftsführung
- LIEBERMAN, Naftoli Meir
- PRUIM, David
- RUSSELL, Yitzhok Elhonon
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- private-limited-guarant-nsc-limited-exemption
- Gründungsdatum
- 23.02.2015
- Gelöscht am:
- 2022-01-05
- SIC/NACE
- 85590
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Michael Katz
- Mr Salomon Zvi
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-11-27
- Letzte Einreichung: 2018-02-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-03-08
- Letzte Einreichung: 2019-02-23
-
BOROUGH EDUCATIONAL FOUNDATION Firmenbeschreibung
- BOROUGH EDUCATIONAL FOUNDATION ist eine in Grossbritannien als private-limited-guarant-nsc-limited-exemption registrierte Firma mit der Register-Nr. 09454099. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.02.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "85590" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Frp Advisory Llp Jupiter House Warley Hill Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern BOROUGH EDUCATIONAL FOUNDATION HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Borough Educational Foundation - Frp Advisory Llp Jupiter House Warley Hill Business Park, The Drive, Brentwood, Essex, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BOROUGH EDUCATIONAL FOUNDATION aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-compulsory-winding-up-progress-report (2020-09-18) - WU07
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-19) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-25) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-29) - PSC07
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-05-08) - MR04
-
gazette-notice-compulsory (2019-05-14) - GAZ1
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-05-23) - LIQ02
-
resolution (2019-05-23) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-05-23) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-24) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-03) - CS01
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2019-07-10) - COCOMP
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-24) - AD01
-
liquidation-compulsory-appointment-liquidator (2019-09-24) - WU04
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-11-30) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-13) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-19) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-15) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-03-06) - TM02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-02-22) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-17) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-16) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-22) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-22) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-11-22) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-22) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-12) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-09-03) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2016-04-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed (2015-09-29) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-25) - MR01
-
incorporation-company (2015-02-23) - NEWINC