-
CAMBRIDGE & DISTRICT PROPERTIES LIMITED - 5 Leys Avenue, Letchworth Garden City, Herts, SG6 3EA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09431196
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5 Leys Avenue
- Letchworth Garden City
- Herts
- SG6 3EA
- England 5 Leys Avenue, Letchworth Garden City, Herts, SG6 3EA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ROBINSON, Tony
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.02.2015
- Gelöscht am:
- 2021-03-23
- SIC/NACE
- 55900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Melvin Douglas Willis
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-01-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-06-09
- Letzte Einreichung: 2019-05-26
-
CAMBRIDGE & DISTRICT PROPERTIES LIMITED Firmenbeschreibung
- CAMBRIDGE & DISTRICT PROPERTIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09431196. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 10.02.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "55900" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 5 Leys Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern CAMBRIDGE & DISTRICT PROPERTIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cambridge & District Properties Limited - 5 Leys Avenue, Letchworth Garden City, Herts, SG6 3EA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CAMBRIDGE & DISTRICT PROPERTIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-notice-compulsory (2020-11-17) - GAZ1
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-02-05) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-07) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-10-14) - MR04
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-08-31) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-29) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-08-20) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-17) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-12) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-05-18) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-05-16) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-05-05) - MR01
-
capital-allotment-shares (2016-04-13) - SH01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-04-07) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-31) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-21) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-21) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-10) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-15) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-02-10) - NEWINC